THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02973803 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED?
- (9261) /
- (9272) /
Wo befindet sich THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BIG CITY PROPERTIES LIMITED | 05. Okt. 1994 | 05. Okt. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Okt. 2011 | 3 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Grant Way Isleworth Middlesex TW7 5QD am 05. Nov. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Christopher Jon Taylor als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von David Joseph Gormley als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Darroch als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Griffith als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Mai 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. Mai 2010
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 43 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 26 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 18 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORMLEY, David Joseph | Sekretär | Grant Way TW7 5QD Isleworth Middlesex | British | 150780210001 | ||||||
GORMLEY, David Joseph | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth British Sky Broadcasting Group Plc Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 150780210001 | ||||
TAYLOR, Christopher Jon | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth British Sky Broadcasting Group Plc Middlesex United Kingdom | England | British | Company Secretary | 135143490001 | ||||
BOLGER, Patrick Anthony | Sekretär | 31 Alverstone Avenue Wimbledon Park SW19 8BD London | Irish | Chartered Accountant | 37660110001 | |||||
DOBSON, Laura Jane | Sekretär | 18 Berkeley Mews Thames Street TW16 5QF Lower Sunbury Middlesex | British | 73308490001 | ||||||
GORMLEY, David Joseph | Sekretär | 17 Middleton Drive HA5 2PQ Pinner Middlesex | British | 150780210001 | ||||||
PRICE, Simon John | Sekretär | 2 Hawkwell Church Crookham GU13 0XF Fleet Hampshire | British | Accountant | 57781400003 | |||||
WOOD, Mark Andrew Kenneth | Sekretär | 52 Leeds Road YO8 4JQ Selby North Yorkshire | British | Director | 113494040001 | |||||
FORBES SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 8-10 Half Moon Court EC1A 7HE London | 900007720001 | |||||||
MCS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 82 St John Street EC1M 4JN London | 39349220001 | |||||||
BALL, Anthony Frank Elliott | Geschäftsführer | 6 Buckingham House Courtlands Sheen Road TW10 5AP Richmond Surrey | British | Chief Executive Officer | 49642300006 | |||||
BOLGER, Patrick Anthony | Geschäftsführer | 31 Alverstone Avenue Wimbledon Park SW19 8BD London | Irish | Chartered Accountant | 37660110001 | |||||
DARROCH, David Jeremy | Geschäftsführer | British Sky Broadcasting Group Plc Grant Way TW7 5QD Isleworth Middlesex | England | British | Chief Executive Officer | 184936660001 | ||||
FENN, Jeremy Mark | Geschäftsführer | 4 Stone Rings Grange HG2 9HU Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Director | 69458580005 | ||||
GRIFFITH, Andrew John | Geschäftsführer | British Sky Broadcasting Group Plc Grant Way TW7 5QD Isleworth Middlesex | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 129926510001 | ||||
MURDOCH, James Rupert | Geschäftsführer | British Sky Broadcasting Group Plc Grant Way TW7 5QD Isleworth Middlesex | British | Chief Executive | 98054190002 | |||||
PRICE, Simon John | Geschäftsführer | 2 Hawkwell Church Crookham GU13 0XF Fleet Hampshire | British | Accountant | 57781400003 | |||||
STEWART, Martin David | Geschäftsführer | 123 Buckingham Palace Road SW1W 9SL London | British | Chartered Accountant | 49920470007 | |||||
WILSON, Herbert James Mervyn | Geschäftsführer | Burwood Park Cottage 2 Eriswell Road KT12 5BW Burwood Park Surrey | British | Turf Accountant | 18417070001 | |||||
WOOD, Mark Andrew Kenneth | Geschäftsführer | 52 Leeds Road YO8 4JQ Selby North Yorkshire | England | British | Commercial Director | 113494040001 | ||||
FORBES NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 8-10 Half Moon Court EC1A 7HE London | 900007710001 | |||||||
MCS NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 82 St John Street EC1M 4JN London | 40236920001 |
Hat THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Erstellt am 20. Juni 2000 Geliefert am 24. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Juli 1997 Geliefert am 14. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The principal at any time but excluding the investment income from time to time earned there on (both capitalised terms having the meaning given thereto in section 11-2.1(b) of the new york estates powers and trusts law) and the property in the actual and sole possession of the trustee (or held by the trustee in the name of a nominee at any time and held under the provisions of the trust deed allocable to the particular trust created by the company with respect to the particular year of account of the relevant syndicate and cash drawn down on any letter of credit at any time and held as an asset of the fund held under the provisions of the trust deed and other property referred to in the trust deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 25. Juli 1996 Geliefert am 13. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat THE SURREY GOLF COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0