NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02984572 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED?
- Erzeugung von Elektrizität (35110) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft
Wo befindet sich NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Frp Advisory Trading Limited 4th Floor Abbey House M2 4AB 32 Booth Street Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ARBUTUS PROJECTS (UK) LIMITED | 30. Dez. 2002 | 30. Dez. 2002 |
| CLP PROJECTS LIMITED | 29. März 1995 | 29. März 1995 |
| ROXWELL ENERGY LIMITED | 28. Okt. 1994 | 28. Okt. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Okt. 2022 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom First Floor 500 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7YJ zum C/O Frp Advisory Trading Limited 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB am 03. Nov. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Keith Alan Reid als Direktor am 23. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Damien Holton als Geschäftsführer am 01. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von James Huxley Milne als Direktor am 08. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Neville Hardman als Geschäftsführer am 08. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Edward Hinton als Geschäftsführer am 08. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eric Philippe Marianne Machiels als Geschäftsführer am 08. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Jonathan Gregson als Geschäftsführer am 08. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Michael Holton als Direktor am 08. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG, Jacqueline | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213710001 | |||||||
| MILNE, James Huxley | Geschäftsführer | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 220566330001 | |||||
| PICKERING, Stephen Shane | Geschäftsführer | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 198076630001 | |||||
| REID, Keith Alan | Geschäftsführer | NN4 7YJ Northampton Business Park First Floor 500 Pavilion Drive Northampton United Kingdom | United Kingdom | British | 179486220003 | |||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246050001 | |||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194567030001 | |||||||
| CALDER, Samantha Jane | Sekretär | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | British | 75830790003 | ||||||
| CRAIG, Martin | Sekretär | 6 Burlington Road N10 1NJ London | British | 40902650003 | ||||||
| FITZHERBERT, David Henry | Sekretär | 12 Gordon Place W8 4JD London | Irish | 74254060001 | ||||||
| OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Sekretär | 19 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GF Bath | British | 98205520001 | ||||||
| PENTECOST, Alexandra Helen | Sekretär | 2 Stratton Villas Milbourne SN16 9JB Malmesbury Wiltshire | British | 70254590001 | ||||||
| TEMPLES (NOMINEES) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004500001 | |||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| AXFORD, Eric Sidney | Geschäftsführer | La Pierre Blanche Mont Es Croix JE3 8EN St Brelade Jersey C I | Jersey | British | 56102260002 | |||||
| BOYD, Gordon Alexander | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | England | British | 148856600001 | |||||
| EDWARDS, Mark Simon | Geschäftsführer | 2 Brook House Court Lakeside Road WA13 0GR Lymm Cheshire | British | 109659860001 | ||||||
| FITZHERBERT, David Henry | Geschäftsführer | 12 Gordon Place W8 4JD London | United Kingdom | Irish | 74254060001 | |||||
| FITZSIMMONS, David Stephen | Geschäftsführer | Hammer Tower Penshurst TN11 8HZ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 109928450001 | |||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | England | British | 154908310001 | |||||
| HARDMAN, Steven Neville | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | Uk | British | 93743250007 | |||||
| HEWSON, John Francis | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | United Kingdom | British | 120308140001 | |||||
| HINTON, Thomas Edward | Geschäftsführer | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||
| HOLTON, Michael Damien | Geschäftsführer | NN4 7YJ Northampton Business Park First Floor 500 Pavilion Drive Northampton United Kingdom | England | British | 220533770001 | |||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | Belgian | 125748990002 | |||||
| MILLER, David Muir | Geschäftsführer | The Old Boat House Inn 1 Warrington Lane WA13 0UH Lymm Cheshire | United Kingdom | British | 69864850004 | |||||
| QUINLAN, Rory John | Geschäftsführer | Flat 12 25 Queen's Gate Gardens South Kensington SW7 5RP London | Australian | 113941780001 | ||||||
| ROUND, Richard Calvin | Geschäftsführer | Elimbriar 8 Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Beds | Uk | British | 108158250002 | |||||
| WEST, Andrew Thomas | Geschäftsführer | 4 Filkins Hall Filkins GL7 3JJ Lechdale Gloucestershire | United Kingdom | British | 79568920001 | |||||
| WYNDHAM, Harry Hugh Patrick | Geschäftsführer | 56 Stockwell Park Crescent SW9 0DG London | England | British | 37118660001 | |||||
| TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004490001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novera Energy (Holdings 2) Limited | 06. Apr. 2016 | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton 500 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2012 Geliefert am 21. Sept. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Feb. 2006 Geliefert am 17. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right,title and interest from time to time in and to each of the following assets,the real property,the tangible moveable property,the accounts,the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge deed | Erstellt am 23. Nov. 1995 Geliefert am 13. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any financing document or hedging instrument pursuant to clause 2 of the deed as defined therein | |
Kurze Angaben All of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Cross guarantee and debenture | Erstellt am 23. Nov. 1995 Geliefert am 13. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies as defined therein to the chargee under any financing document or hedging instrument as defined in the cross guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0