LR (STRATFORD) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LR (STRATFORD) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02984604 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LR (STRATFORD) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich LR (STRATFORD) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LR (STRATFORD) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HAWKSWAN LIMITED | 28. Okt. 1994 | 28. Okt. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LR (STRATFORD) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LR (STRATFORD) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Nigel Luck als Sekretär am 02. Mai 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Springer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Leonard Kevin Chandran Sebastian als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Livingstone als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LR (STRATFORD) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN, Leonard Kevin Chandran | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Floor 6 Quadrant House United Kingdom | England | Swiss | Group Managing And Legal Director | 127493570001 | ||||
ALLEN, Colin | Sekretär | 14 Oxford Gardens Whetstone N20 9AG London | British | 26500690001 | ||||||
LETHABY, Michael Richard | Sekretär | Tye Cottage 6 Childsbridge Lane Seal TN15 0BL Sevenoaks Kent | British | 49511390001 | ||||||
LIVINGSTONE, Richard John | Sekretär | 40 New Bond Street W1Y 9HB London | British | Surveyor | 47212090001 | |||||
LUCK, Richard Nigel | Sekretär | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | British | 61070930002 | ||||||
CITY REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 4th Floor St Alphage House 2 Fore Street EC2Y 5DH London | 900010930001 | |||||||
KING, Christopher | Geschäftsführer | 53 Kings Road TW10 6EG Richmond Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 77423330002 | ||||
LIVINGSTONE, Ian Malcolm | Geschäftsführer | NW1 | United Kingdom | British | Company Director | 75831270005 | ||||
LIVINGSTONE, Richard John | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 140052910001 | ||||
LIVINGSTONE, Richard John | Geschäftsführer | 40 New Bond Street W1Y 9HB London | British | Surveyor | 47212090001 | |||||
SPRINGER, Geoffrey Antony | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 1738150002 | ||||
CITY EXECUTOR AND TRUSTEE COMPANY LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 4t Floor St Alphage House 2 Fore Street EC2Y 5DH London | 900010920001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LR (STRATFORD) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London & Regional Group Securitisation No.2 Limited | 06. Apr. 2016 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat LR (STRATFORD) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Erstellt am 28. Juli 2006 Geliefert am 08. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Town square shopping centre, high street, wood street, straford-upon-avon f/h and l/h property (f/h t/ns) WK363501, WK363505, WK312215, WK373204 and WK373205 and (l/h t/ns) WK407493, WK373202, WK373201, WK307817 and WK387753. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over construction contract | Erstellt am 15. Juli 2004 Geliefert am 30. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its present and future rights title and interests in and to the contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Juli 2004 Geliefert am 30. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the properties being town square shopping centre stratford-upon-avon warwickshire t/no WK407493, part of first floor 30 high street stratford-upon-avon warwickshire t/no WK387753, 31 high street stratford-upon-avon warwickshire t/no WK373201 for further details of the properties carged please refer to the form 395 by way of first fixed charge all property and all interest in property all plant and machinery goodwill and uncalled capital by way of floating charge all its present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit | Erstellt am 15. Juli 2004 Geliefert am 30. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit with all the companies present and future rights titles and benefit in it to the security agent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Mai 2001 Geliefert am 29. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of the company owed or expressed to be owed to the bank under: (a) the loan agreement or any other finance document; (b) the kws guarantee | |
Kurze Angaben All that l/h property k/a the bell court shopping centre, statford-upon-avon t/n WK373200, all that f/h property k/a 3 taskers way, stratford-upon-avon t/n WK380545, all that f/h property k/a 14, 15 and 15A wood street, stratford-upon-avon t/n WK373204. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0