CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02990331 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 20 West Mills RG14 5HG Newbury Berkshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CHATSWORTH HOMES (SOUTH WEST) LIMITED | 31. Aug. 1999 | 31. Aug. 1999 |
WILTSHIRE COUNTY HOMES LIMITED | 15. Nov. 1994 | 15. Nov. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Kevin Stephen Jeffrey Batt am 15. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 32 Darnley Avenue Bristol BS7 0BS am 09. Okt. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORSEY, John Sebastian Norman James | Sekretär | 20 West Mills RG14 5HG Newbury Berkshire | Other | Solicitor | 30903730001 | |||||
BATT, Kevin Stephen Jeffrey | Geschäftsführer | Many Views 2 The Scop Almondsbury BS32 4DU Bristol | United Kingdom | British | Construction Manager | 5018980005 | ||||
HORSEY, John Sebastian Norman James | Sekretär | 20 West Mills RG14 5HG Newbury Berkshire | Other | Solicitor | 30903730001 | |||||
JAMES, Geraint Hugh | Sekretär | 7 Beaufort West Grosvenor London Road BA1 6QB Bath | British | Solicitor | 59176220001 | |||||
NOMINEE SECRETARIES LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006780001 | |||||||
BRETON, Anthony Moyle | Geschäftsführer | 7 Elms Way West Wittering PO20 8LS Chichester West Sussex | British | Farmer | 46022370001 | |||||
HORSEY, John Sebastian Norman James | Geschäftsführer | 20 West Mills RG14 5HG Newbury Berkshire | United Kingdom | Other | Solicitor | 30903730001 | ||||
PONSFORD, Barry Anthony Lloyd | Geschäftsführer | Regent House Eastcourt Burbage SN8 3AG Marlborough Wiltshire | British | Architecture | 57303030002 | |||||
NOMINEE DIRECTORS LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006850001 |
Hat CHATSWORTH HOMES (SPECIAL PROJECTS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 30. Juni 2009 Geliefert am 17. Juli 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £15,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 6 kings field rangeworthy bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Nov. 2006 Geliefert am 06. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second legal charge | Erstellt am 23. Jan. 2006 Geliefert am 02. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £235,625.00 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben Property k/a land adjoining chelsea new road, rangeworthy, south gloucestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Jan. 2006 Geliefert am 02. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land adjacent to "chelsea" new road rangeworthy south gloucestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 24. Okt. 2002 Geliefert am 05. Nov. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at village farm easter compton nr bristol. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Sept. 2002 Geliefert am 16. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land at village farm easter compton near bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 11. Feb. 2000 Geliefert am 21. Feb. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 11. Feb. 2000 Geliefert am 18. Feb. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at stanshawes court drive yate bristol. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Juni 1995 Geliefert am 08. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The old coalyard anchor road, calne wiltshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 04. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a the old coalyard site off anchor road calne wiltshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0