BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED

BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02990953
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite 9 The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    South Humberside
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CHARGENOTICE LIMITED16. Nov. 199416. Nov. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Carlton Greener als Geschäftsführer am 11. März 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Denise Brenda Robinson als Geschäftsführer am 08. März 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Trevor Martin Sands als Geschäftsführer am 08. März 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Denise Brenda Robinson als Sekretär am 08. März 2013

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    3 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Origin 4 Origin Way Europarc Grimsby South Humberside DN37 9TZ United Kingdom am 04. Sept. 2012

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Trevor Martin Sands als Direktor am 30. Apr. 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. März 2012

    Kapitalaufstellung am 23. März 2012

    • Kapital: GBP 386,734.5
    SH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Okt. 2011 bis 31. Dez. 2011

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Mrs Denise Brenda Robinson als Direktor am 30. Sept. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Neil Richard Carrick als Geschäftsführer am 30. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Enter into facilities agreement 29/11/2010
    RES13

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Nov. 2009

    4 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Fish Dock Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3NW am 12. Mai 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Carlton Greener am 31. März 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Neil Richard Carrick am 31. März 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Denise Brenda Robinson am 31. März 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Okt. 2008

    4 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Facilities agreement 31/07/2009
    RES13

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FOXFORD, Michael John
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    Sekretär
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    BritishCompany Secretary96216260001
    GREENER, Carlton
    3
    Roewood Lane
    SK10 2PQ Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    3
    Roewood Lane
    SK10 2PQ Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant290436370002
    ROBINSON, Denise Brenda
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Sekretär
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary112343690001
    ROBSON, Alan James
    14 Mill Place
    DN35 8ND Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    Sekretär
    14 Mill Place
    DN35 8ND Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    British74547040004
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BROWNE, Peter
    11 Ravenhill Park Gardens
    BT6 0DH Belfast
    Geschäftsführer
    11 Ravenhill Park Gardens
    BT6 0DH Belfast
    BritishDevelopment Director42230710001
    CARRICK, Neil Richard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant166312330001
    GREENER, Carlton
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant290436370002
    JONSSON, Per Anders
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    EnglandSwedishChief Executive189569310001
    MEADOWCROFT, Norman Russell
    3 Barley Drive
    Bramhall
    SK7 2QB Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Barley Drive
    Bramhall
    SK7 2QB Stockport
    Cheshire
    BritishConsultant28601500001
    MEDDINGS, David William
    13 Montagu Square
    W1H 1RB London
    Geschäftsführer
    13 Montagu Square
    W1H 1RB London
    BritishChartered Accountant4416070001
    ROBINSON, Denise Brenda
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary112343690001
    RUSSELL, Richard
    12 Beechfield Drive
    CW10 9QE Middlewich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Beechfield Drive
    CW10 9QE Middlewich
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director41506100001
    SANDS, Trevor Martin
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomUnited KingdomDirector164235220001
    SMALLBONE, Timothy Charles
    22 Crossway
    Didsbury
    M20 6TT Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    22 Crossway
    Didsbury
    M20 6TT Manchester
    Lancashire
    BritishAccountant42089430001
    STEVENSON, James Neil
    Rathlin
    Hallpath
    DG13 0EG Langholm
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    Rathlin
    Hallpath
    DG13 0EG Langholm
    Dumfriesshire
    ScotlandBritishCompany Director759350001
    THOMAS, Adrian Peter Harrison
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director26500450003
    TURNHEIM, Stuart
    33 Breeze Mount
    Prestwich
    M25 0AH Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    33 Breeze Mount
    Prestwich
    M25 0AH Manchester
    Lancashire
    BritishSales Director41506080001
    WOOD, Frederick William
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritishChartered Accountant3783250004
    WOOLLEY, Anthony
    22 Cross Street
    DE22 3FZ Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    22 Cross Street
    DE22 3FZ Derby
    Derbyshire
    BritishTechnical Director42230670001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Hat BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 26. März 2009
    Geliefert am 09. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Frederick William Wood, Ronald Briggs Heaton, Paul Arthur Bradbury, Alan Smith and Vincent Rodger Whyte Mccracken as the Trustees of the Cosalt Retirement Plan
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. März 2009
    Geliefert am 04. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage which was presented for registration in northern ireland on 17TH september 1997
    Erstellt am 12. Sept. 1997
    Geliefert am 25. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that piece or parcel of ground situate on the south side of the road leading from ballyclare to ballynure k/a the ballynure road situate lying and being in le ballyclare in the parish of ballynure and county of antrim. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 06. Okt. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1997
    Geliefert am 17. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of permanent health policy
    Erstellt am 25. Okt. 1995
    Geliefert am 26. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of protection plan policy
    Erstellt am 25. Okt. 1995
    Geliefert am 26. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment) with sun alliance and london assurance company liited and all money that may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 27. Jan. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 27. Jan. 1995
    Geliefert am 01. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Jan. 1995
    Geliefert am 30. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Jan. 1995
    Geliefert am 30. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that piece or parcel of ground situate at 44 ballyclare road ballyclare le ballyclare in the parish of ballyclare and county of antrim and the present or future goodwiull of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0