BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02990953 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suite 9 The Innovation Centre Innovation Way Europarc DN37 9TT Grimsby South Humberside United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CHARGENOTICE LIMITED | 16. Nov. 1994 | 16. Nov. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carlton Greener als Geschäftsführer am 11. März 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Denise Brenda Robinson als Geschäftsführer am 08. März 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Martin Sands als Geschäftsführer am 08. März 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Denise Brenda Robinson als Sekretär am 08. März 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Origin 4 Origin Way Europarc Grimsby South Humberside DN37 9TZ United Kingdom am 04. Sept. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Trevor Martin Sands als Direktor am 30. Apr. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Okt. 2011 bis 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Denise Brenda Robinson als Direktor am 30. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Richard Carrick als Geschäftsführer am 30. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Nov. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Fish Dock Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3NW am 12. Mai 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Carlton Greener am 31. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Neil Richard Carrick am 31. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Denise Brenda Robinson am 31. März 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Okt. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXFORD, Michael John | Sekretär | 5 Cooper Street M2 2FW Manchester Greater Manchester | British | Company Secretary | 96216260001 | |||||
GREENER, Carlton | Sekretär | 3 Roewood Lane SK10 2PQ Macclesfield Cheshire | British | Accountant | 290436370002 | |||||
ROBINSON, Denise Brenda | Sekretär | The Innovation Centre Innovation Way Europarc DN37 9TT Grimsby Suite 9 South Humberside United Kingdom | British | Company Secretary | 112343690001 | |||||
ROBSON, Alan James | Sekretär | 14 Mill Place DN35 8ND Cleethorpes North East Lincolnshire | British | 74547040004 | ||||||
BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
BROWNE, Peter | Geschäftsführer | 11 Ravenhill Park Gardens BT6 0DH Belfast | British | Development Director | 42230710001 | |||||
CARRICK, Neil Richard | Geschäftsführer | Origin Way Europarc DN37 9TZ Grimsby Origin 4 South Humberside United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 166312330001 | ||||
GREENER, Carlton | Geschäftsführer | The Innovation Centre Innovation Way Europarc DN37 9TT Grimsby Suite 9 South Humberside United Kingdom | England | British | Accountant | 290436370002 | ||||
JONSSON, Per Anders | Geschäftsführer | 263 Petersham Road TW10 7DA Richmond Surrey | England | Swedish | Chief Executive | 189569310001 | ||||
MEADOWCROFT, Norman Russell | Geschäftsführer | 3 Barley Drive Bramhall SK7 2QB Stockport Cheshire | British | Consultant | 28601500001 | |||||
MEDDINGS, David William | Geschäftsführer | 13 Montagu Square W1H 1RB London | British | Chartered Accountant | 4416070001 | |||||
ROBINSON, Denise Brenda | Geschäftsführer | The Innovation Centre Innovation Way Europarc DN37 9TT Grimsby Suite 9 South Humberside United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 112343690001 | ||||
RUSSELL, Richard | Geschäftsführer | 12 Beechfield Drive CW10 9QE Middlewich Cheshire | United Kingdom | British | Managing Director | 41506100001 | ||||
SANDS, Trevor Martin | Geschäftsführer | The Innovation Centre Innovation Way Europarc DN37 9TT Grimsby Suite 9 South Humberside United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | Director | 164235220001 | ||||
SMALLBONE, Timothy Charles | Geschäftsführer | 22 Crossway Didsbury M20 6TT Manchester Lancashire | British | Accountant | 42089430001 | |||||
STEVENSON, James Neil | Geschäftsführer | Rathlin Hallpath DG13 0EG Langholm Dumfriesshire | Scotland | British | Company Director | 759350001 | ||||
THOMAS, Adrian Peter Harrison | Geschäftsführer | 26 Hartley Road WA14 4AY Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 26500450003 | ||||
TURNHEIM, Stuart | Geschäftsführer | 33 Breeze Mount Prestwich M25 0AH Manchester Lancashire | British | Sales Director | 41506080001 | |||||
WOOD, Frederick William | Geschäftsführer | Pleasant House Pleasant Place LN11 0NA Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 3783250004 | ||||
WOOLLEY, Anthony | Geschäftsführer | 22 Cross Street DE22 3FZ Derby Derbyshire | British | Technical Director | 42230670001 | |||||
DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Hat BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite debenture | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 09. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 04. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage which was presented for registration in northern ireland on 17TH september 1997 | Erstellt am 12. Sept. 1997 Geliefert am 25. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that piece or parcel of ground situate on the south side of the road leading from ballyclare to ballynure k/a the ballynure road situate lying and being in le ballyclare in the parish of ballynure and county of antrim. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Sept. 1997 Geliefert am 17. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of permanent health policy | Erstellt am 25. Okt. 1995 Geliefert am 26. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment the policy (as defined in the assignment). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of protection plan policy | Erstellt am 25. Okt. 1995 Geliefert am 26. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment the policy (as defined in the assignment) with sun alliance and london assurance company liited and all money that may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 27. Jan. 1995 Geliefert am 10. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of life policy | Erstellt am 27. Jan. 1995 Geliefert am 01. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment the policy (as defined in the assignment) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Jan. 1995 Geliefert am 30. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 1995 Geliefert am 30. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that piece or parcel of ground situate at 44 ballyclare road ballyclare le ballyclare in the parish of ballyclare and county of antrim and the present or future goodwiull of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0