GROVE FRESH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGROVE FRESH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02994068
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GROVE FRESH LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich GROVE FRESH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GROVE FRESH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FLORIDA EXPORTS LIMITED18. Nov. 199418. Nov. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GROVE FRESH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GROVE FRESH LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GROVE FRESH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft

    1 SeitenDS02

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Wellness Foods Limited Orchard Lea Winkfield Lane Winkfield Windsor SL4 4RU zum 72 Manton Road Earlstrees Industrial Estate Corby Northants NN17 4JL geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3000 Hillswood Business Park Hillswood Drive Chertsey England KT16 0RS zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 26. Nov. 2014

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Nov. 2014

    LRESSP

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    14 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 05. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 8,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    17 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Gerard Vincent Magee am 28. Okt. 2011

    2 SeitenCH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Änderung der Details des Sekretärs für Mark John Lane am 21. Okt. 2011

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mark John Lane am 21. Okt. 2011

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von GROVE FRESH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LANE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Sekretär
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British151310030001
    LANE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British132183700001
    MAGEE, Gerard Vincent
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    IrelandIrish151272980001
    ASHBY, David John
    20 Earlsbrook Road
    RH1 6DP Redhill
    Surrey
    Sekretär
    20 Earlsbrook Road
    RH1 6DP Redhill
    Surrey
    British102448200001
    BAILEY, Betty Patricia
    17 Browning Road
    Fetcham
    KT22 9HN Leatherhead
    Surrey
    Sekretär
    17 Browning Road
    Fetcham
    KT22 9HN Leatherhead
    Surrey
    British27277550001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    SHUPICK, Andrew Colin
    21 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Sekretär
    21 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    British42780010003
    WSM SERVICES LIMITED
    Derwent House
    35 South Park Road
    SW19 8RR London
    Sekretär
    Derwent House
    35 South Park Road
    SW19 8RR London
    30807900001
    HATTON, Christina Dorothy
    32 Belmont Rise
    Cheam
    SM2 6EQ Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    32 Belmont Rise
    Cheam
    SM2 6EQ Sutton
    Surrey
    British43261850001
    HOLLOWELL, Trevor
    Carden Marsh
    Carden Tilston
    SY14 7HR Malpas
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Carden Marsh
    Carden Tilston
    SY14 7HR Malpas
    Cheshire
    British40326570001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish107745290001
    PARSONS, Howard Lewis
    3 The Downs Llhergy Cripperty
    Union Mills
    IM4 4NQ Douglas
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    3 The Downs Llhergy Cripperty
    Union Mills
    IM4 4NQ Douglas
    Isle Of Man
    British43336610001
    SCHREUDER, Willem Meindert
    1m Stillen Winkel 3
    Krefeld
    D47804
    Germany
    Geschäftsführer
    1m Stillen Winkel 3
    Krefeld
    D47804
    Germany
    Dutch95349710001
    SHEWRING, David
    14 Crooms Hill
    Greenwich
    SE10 8ER London
    Geschäftsführer
    14 Crooms Hill
    Greenwich
    SE10 8ER London
    British41904940001
    SHUPICK, Andrew Colin
    21 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    21 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish42780010003
    TAYLOR, Mark John
    North Croft
    Station Road
    CR3 7DE Woldingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    North Croft
    Station Road
    CR3 7DE Woldingham
    Surrey
    United KingdomBritish9677100002
    TAYLOR, Nancy Jane
    6 South Park Mews
    Fulham
    SW6 3AY London
    Geschäftsführer
    6 South Park Mews
    Fulham
    SW6 3AY London
    UkBritish19800190002
    TOOMEY, John Francis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish164624980001

    Hat GROVE FRESH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A supplemental deed
    Erstellt am 13. Jan. 2010
    Geliefert am 14. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 24. Dez. 2009
    Geliefert am 08. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over any right title or interest in any land and all shareas related rights and all distribution rights thereon; all investments and related rights all book debts benefits and security thereon; all non trading debts and all benefits rights and security thereunder; fixed charge over all amounts standing to the credit of each account and any other amount; all property rights all fees royalties and other rights thereon; the goodwill and uncalled capital and benefit of all authorisations held in relation to any security interest; all insurances and floating charge over all undertaking and assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security accession deed
    Erstellt am 14. Jan. 2009
    Geliefert am 27. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Part second floor offices saxley court victoria road horley t/no SY742440; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed
    Erstellt am 14. März 2008
    Geliefert am 31. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 31. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security accession deed
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 05. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Part second floor offices, saxley court, victoria road, horley t/no SY742440 by way of fixed charge the land; shares; investments; equipment and book debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 05. Jan. 2007
    Geliefert am 10. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GROVE FRESH LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Nov. 2014Beginn der Liquidation
    01. Juli 2015Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0