RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02998088
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SCOREFIRST SYSTEMS LIMITED05. Dez. 199405. Dez. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    legacy

    94 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    3 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 05. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 20. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Tillbrook als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Sekretär
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151414340001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    HUNT, Clair Elizabeth
    The Pound House
    The Pound
    SL6 9QD Cookham
    Berkshire
    Sekretär
    The Pound House
    The Pound
    SL6 9QD Cookham
    Berkshire
    British95562280001
    PEACE, Caroline Amanda
    Harvest Home
    3 Sack Lane Cottage, Sack Lane
    PO22 9PD Lidsey
    West Sussex
    Sekretär
    Harvest Home
    3 Sack Lane Cottage, Sack Lane
    PO22 9PD Lidsey
    West Sussex
    British75009050003
    ALPHA SECRETARIAL LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    Bevollmächtigter Sekretär
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900004510001
    TELEWEST SECRETARIES LIMITED
    Export House
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Surrey
    Sekretär
    Export House
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Surrey
    92359500001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    HIRD, David John
    17 Ascot House
    North Third Street
    MK9 3LZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    17 Ascot House
    North Third Street
    MK9 3LZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British69620800001
    HUNT, Lawrence William
    The Pound House
    The Pound
    SL6 9QD Crookham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Pound House
    The Pound
    SL6 9QD Crookham
    Berkshire
    British41558760001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MCDAID, Brian Dominic Bosco
    Kilnsey
    Manor Road Horsell
    GU21 4RY Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Kilnsey
    Manor Road Horsell
    GU21 4RY Woking
    Surrey
    British41993630001
    MOUNTFIELD, Steven
    12 Keyfield Terrace
    AL1 1QH St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    12 Keyfield Terrace
    AL1 1QH St Albans
    Hertfordshire
    British67082920001
    PARKEY, John Derek
    Moor End Cottage
    London Road
    HP1 2RE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Moor End Cottage
    London Road
    HP1 2RE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish58497910003
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    WEBBER, Keith Alan
    The Slade Oasts
    The Slade
    TN3 8HN Lamberhurst
    Kent
    Geschäftsführer
    The Slade Oasts
    The Slade
    TN3 8HN Lamberhurst
    Kent
    United KingdomBritish30546730001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    ALPHA DIRECT LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900001400001
    TELEWEST DIRECTORS LIMITED
    Export House
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Export House
    Cawsey Way
    GU21 6QX Woking
    Surrey
    92359560001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Hat RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. Mai 2001
    Geliefert am 26. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a deed of guarantee of even date given by the company in respect of the obligations of rapid travel solutions limited ("rts") to the chargees pursuant to a loan and option agreement between (inter alia) rts and the chargees dated 10 may 2001
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • (1) Lawrence Hunt (2) David Hurd (3) David Guillebaud (4) Steve Mountfield
    Transaktionen
    • 26. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 10. Apr. 2000
    Geliefert am 12. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Monies standing to the credit of a deposit account and due from the company to the chargee under a lease of even date over premises known as unit 2B badminton court,amersham,buckinghamshire
    Kurze Angaben
    The deposit account (initially £25,000) and all money from time to time withdrawn from the account.
    Berechtigte Personen
    • Boardfence Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 07. Apr. 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the 21ST century cybertravel company limited to the chargee on any account whatsoever,provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Kurze Angaben
    Business premium account no.50754935. The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 07. Apr. 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and rapid travel solutions limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed relating to rent deposit
    Erstellt am 23. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The payment by the company (the tenant) of the rent reserved by the lease and all other moneys becoming due to the chargee under the lease and under the rent deposit deed
    Kurze Angaben
    The account being the deposit account in the sole name of the chargee (the landlord) at charterhouse bank limited and the deposit sum of £25,000 and all amounts from time to time standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Boardfence Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0