RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02998088 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SCOREFIRST SYSTEMS LIMITED | 05. Dez. 1994 | 05. Dez. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 94 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 92 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Tillbrook als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | 151414340001 | |||||||
| DUNN, Robert Dominic | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 179134020002 | |||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 182167230001 | |||||
| BURNS, Clive | Sekretär | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||
| HUNT, Clair Elizabeth | Sekretär | The Pound House The Pound SL6 9QD Cookham Berkshire | British | 95562280001 | ||||||
| PEACE, Caroline Amanda | Sekretär | Harvest Home 3 Sack Lane Cottage, Sack Lane PO22 9PD Lidsey West Sussex | British | 75009050003 | ||||||
| ALPHA SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2nd Floor 83 Clerkenwell Road EC1R 5AR London | 900004510001 | |||||||
| TELEWEST SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Export House Cawsey Way GU21 6QX Woking Surrey | 92359500001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 96956740001 | |||||
| HIRD, David John | Geschäftsführer | 17 Ascot House North Third Street MK9 3LZ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 69620800001 | ||||||
| HUNT, Lawrence William | Geschäftsführer | The Pound House The Pound SL6 9QD Crookham Berkshire | British | 41558760001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MCDAID, Brian Dominic Bosco | Geschäftsführer | Kilnsey Manor Road Horsell GU21 4RY Woking Surrey | British | 41993630001 | ||||||
| MOUNTFIELD, Steven | Geschäftsführer | 12 Keyfield Terrace AL1 1QH St Albans Hertfordshire | British | 67082920001 | ||||||
| PARKEY, John Derek | Geschäftsführer | Moor End Cottage London Road HP1 2RE Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 58497910003 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| WEBBER, Keith Alan | Geschäftsführer | The Slade Oasts The Slade TN3 8HN Lamberhurst Kent | United Kingdom | British | 30546730001 | |||||
| WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 140137570002 | |||||
| ALPHA DIRECT LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2nd Floor 83 Clerkenwell Road EC1R 5AR London | 900001400001 | |||||||
| TELEWEST DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Export House Cawsey Way GU21 6QX Woking Surrey | 92359560001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107430002 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 |
Hat RAPID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 10. Mai 2001 Geliefert am 26. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a deed of guarantee of even date given by the company in respect of the obligations of rapid travel solutions limited ("rts") to the chargees pursuant to a loan and option agreement between (inter alia) rts and the chargees dated 10 may 2001 | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 10. Apr. 2000 Geliefert am 12. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Monies standing to the credit of a deposit account and due from the company to the chargee under a lease of even date over premises known as unit 2B badminton court,amersham,buckinghamshire | |
Kurze Angaben The deposit account (initially £25,000) and all money from time to time withdrawn from the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 07. Apr. 2000 Geliefert am 14. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the 21ST century cybertravel company limited to the chargee on any account whatsoever,provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon | |
Kurze Angaben Business premium account no.50754935. The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 07. Apr. 2000 Geliefert am 14. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and rapid travel solutions limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed relating to rent deposit | Erstellt am 23. Apr. 1997 Geliefert am 09. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment by the company (the tenant) of the rent reserved by the lease and all other moneys becoming due to the chargee under the lease and under the rent deposit deed | |
Kurze Angaben The account being the deposit account in the sole name of the chargee (the landlord) at charterhouse bank limited and the deposit sum of £25,000 and all amounts from time to time standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0