MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED

MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02999519
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED?

    • (1589) /
    • (7487) /

    Wo befindet sich MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LAM COMMUNICATIONS LIMITED08. Dez. 199408. Dez. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Apr. 2012

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Jan. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Juli 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 12. Apr. 2011

    2 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tenon Recovery Aquarium 1-7 King Street Reading Berkshire RG1 2AN am 09. Sept. 2010

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 12. Apr. 2010

    2 Seiten1.3

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    14 Seiten2.34B

    Vorschlag des Verwalters

    28 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    12 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 12. Apr. 2009

    2 Seiten1.3

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    4 Seiten363a

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 12. Apr. 2009

    11 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 12. Apr. 2009

    2 Seiten1.3

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JONES, Richard William
    The Thatched Cottage
    Townfield Lane
    CH1 6NJ Mollington
    Chester
    Sekretär
    The Thatched Cottage
    Townfield Lane
    CH1 6NJ Mollington
    Chester
    British81052980002
    JONES, Richard William
    The Thatched Cottage
    Townfield Lane
    CH1 6NJ Mollington
    Chester
    Geschäftsführer
    The Thatched Cottage
    Townfield Lane
    CH1 6NJ Mollington
    Chester
    BritishDirector81052980002
    PATON, John Shearer
    The Clock House
    Main Road Betley
    CW3 9BH Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Clock House
    Main Road Betley
    CW3 9BH Crewe
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant33014940001
    HULSE, Christopher Thomas
    18 Bramley Court
    Rectory Lane Standish
    WN6 0JZ Wigan
    Lancashire
    Sekretär
    18 Bramley Court
    Rectory Lane Standish
    WN6 0JZ Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director98186320001
    LAM, David
    85 Eastbank Street
    PR8 1DG Southport
    Merseyside
    Sekretär
    85 Eastbank Street
    PR8 1DG Southport
    Merseyside
    BritishConsultant38002050001
    LEUNG, Robert Chirk Wing
    Selworthy Road
    PR8 2HX Southport
    59
    Merseyside
    Sekretär
    Selworthy Road
    PR8 2HX Southport
    59
    Merseyside
    British7463920002
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    CASHIN, Mark Richard
    1 Chenotrie Gardens
    Noctorum Road Noctorum
    L43 9WU Birkenhead
    Merseyside
    Geschäftsführer
    1 Chenotrie Gardens
    Noctorum Road Noctorum
    L43 9WU Birkenhead
    Merseyside
    EnglandBritishCompany Director22950490002
    HULSE, Christopher Thomas
    18 Bramley Court
    Rectory Lane Standish
    WN6 0JZ Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    18 Bramley Court
    Rectory Lane Standish
    WN6 0JZ Wigan
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director98186320001
    LAM, David
    71 Eastbank Street
    PR8 1EJ Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    71 Eastbank Street
    PR8 1EJ Southport
    Merseyside
    BritishCompany Director38002050002
    LAM, Laura
    71a
    Eastbank Street
    PR8 1EJ Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    71a
    Eastbank Street
    PR8 1EJ Southport
    Merseyside
    BritishConsultant54061830003
    LEUNG, Robert Chirk Wing
    Selworthy Road
    PR8 2HX Southport
    59
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Selworthy Road
    PR8 2HX Southport
    59
    Merseyside
    EnglandBritishDirector7463920002
    TRANFIELD, Nicholas John
    37a Warren Drive
    CH45 0JW Wallasey
    Merseyside
    Geschäftsführer
    37a Warren Drive
    CH45 0JW Wallasey
    Merseyside
    EnglandBritishCompany Director37789690002
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    Hat MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    All assets debenture
    Erstellt am 19. Juni 2007
    Geliefert am 22. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • City Invoice Finance LTD
    Transaktionen
    • 22. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 2006
    Geliefert am 30. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Gladman
    Transaktionen
    • 30. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 02. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 21. Juni 2004
    Geliefert am 01. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Euro Sales Finance PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Erstellt am 07. März 2002
    Geliefert am 13. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right,title and interest in and to certain keyman life insurance policies in the names of david lam and laura lam with all monies,bonuses payable thereunder.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No 2 a Limited Partnership Acting by Its Generalpartner, Afm Merseyside Mezzanine Limited
    Transaktionen
    • 13. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. März 2002
    Geliefert am 13. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No 2 a Limited Partnership Acting by Its Generalpartner, Afm Merseyside Mezzanine Limited
    Transaktionen
    • 13. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Nov. 1997
    Geliefert am 03. Dez. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund Limited
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge on debts and related rights
    Erstellt am 27. Jan. 1997
    Geliefert am 28. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under a factoring agreement or otherwise
    Kurze Angaben
    All debts purchased or purported to be purchased by the security holder from the company pursuant to a factoring agreement between the security holder and the company which fail to vest effectively or absolutely in the security holder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bibby Financial Services Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Okt. 1996
    Geliefert am 28. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MRS.LAM'S DELICIOUS FOOD COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Apr. 2006Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gareth Wyn Roberts
    Hurst Morrison Thomson
    5 Fairmile
    RG9 2JR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Praktiker
    Hurst Morrison Thomson
    5 Fairmile
    RG9 2JR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Paul Ellison
    Hurst Morrison Thomson
    5 Fairmile
    RG9 2JR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Praktiker
    Hurst Morrison Thomson
    5 Fairmile
    RG9 2JR Henley On Thames
    Oxfordshire
    2
    DatumTyp
    16. Juni 2009Beginn der Verwaltung
    15. Jan. 2010Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Ellison
    Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Praktiker
    Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Gareth Wyn Roberts
    Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Praktiker
    Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Christopher Ratten
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    3
    DatumTyp
    15. Jan. 2010Beginn der Liquidation
    26. Juli 2012Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Ellison
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Praktiker
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Gareth Wyn Roberts
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berks
    Praktiker
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berks
    Christopher Ratten
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0