PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03000625 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor Park Gate 161-163 Preston Road BN1 6AF Brighton East Sussex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Premier Medical Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2023 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Oval (1673) Limited as a person with significant control on 23. Feb. 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 3 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 030006250011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of Oval (1673) Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Premier Medical Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Beendigung der Bestellung von Robert Colin Goodall als Geschäftsführer am 05. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Henry Otto Brunjes als Geschäftsführer am 05. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARNER, John Douglas | Geschäftsführer | Park Gate 161-163 Preston Road BN1 6AF Brighton 4th Floor East Sussex | England | British | 237751510001 | |||||||||
| ELLISON, Jeremy Simon | Sekretär | 23 Aldbourne Road Burnham SL1 7NJ Slough Buckinghamshire | British | 60049170002 | ||||||||||
| MACLACHLAN, Alexander Edward | Sekretär | The Old Rectory Tidmarsh RG8 8ER Reading Berkshire | British | 2613010001 | ||||||||||
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Sekretär | Rochester Row SW1P 1QT London 17 England |
| 135207160001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BEDFORD, Nicolas Norman | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 147404780001 | |||||||||
| BRUNJES, Henry Otto, Dr | Geschäftsführer | Park Gate 161-163 Preston Road BN1 6AF Brighton 4th Floor East Sussex England | England | British | 57560600003 | |||||||||
| ELLISON, Jeremy Simon | Geschäftsführer | 23 Aldbourne Road Burnham SL1 7NJ Slough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 60049170002 | |||||||||
| FRANKLIN, Peter Mark | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 179089060001 | |||||||||
| GOODALL, Robert Colin, Dr | Geschäftsführer | Park Gate 161-163 Preston Road BN1 6AF Brighton 4th Floor East Sussex | United Kingdom | British | 204383930001 | |||||||||
| HEALEY, Andrew Mark | Geschäftsführer | Lawn Crescent TW9 3NS Richmond 37 Surrey | United Kingdom | British | 77351950001 | |||||||||
| MACLACHLAN, Alexander Edward | Geschäftsführer | The Old Rectory Tidmarsh RG8 8ER Reading Berkshire | England | British | 2613010001 | |||||||||
| MACLACHLAN, Madeleine Paulette | Geschäftsführer | The Old Rectory Tidmarsh RG8 8ER Reading Berkshire | England | British | 54714780001 | |||||||||
| PACKE, Maxwell Gordon | Geschäftsführer | Jessamies Barn Eastleach GL7 3NG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 47686490006 | |||||||||
| SANDERSON, Martin | Geschäftsführer | 5 St James Close Pangbourne RG8 7AP Reading Berkshire | United Kingdom | British | 41284820004 | |||||||||
| SHEARER, Richard John | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 England | United Kingdom | British | 132651920002 | |||||||||
| SINGH, Davinder | Geschäftsführer | 216 Kingshill Road SN1 4NG Swindon | England | British | 47964180002 | |||||||||
| STIRRUP, Mark Christopher | Geschäftsführer | Park Gate 161-163 Preston Road BN1 6AF Brighton 4th Floor East Sussex | England | British | 204383880001 | |||||||||
| VINCENT, James D'Arcy | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 115136550001 | |||||||||
| CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 England |
| 129795770003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Medical Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 161-163 Preston Road BN1 6AF Brighton 4th Floor, Park Gate England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Premier Medical Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 161-163 Preston Road BN1 6AF Brighton 4th Floor, Park Gate England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 19. Jan. 2016 Geliefert am 26. Jan. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and fixed and floating charge | Erstellt am 10. Juli 2008 Geliefert am 16. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of intellectual property (including software) | Erstellt am 23. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 03. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 02. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 22. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on all debts and related rights and floating charge on all other property | Erstellt am 13. Nov. 2000 Geliefert am 16. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the factoring agreement dated the 25 september 2000 | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all (a) specified debts being any book debts the ownership of which shall fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (b) all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account whatsoever; by way of floating charge the undertaking and all the property rights and assets of the company including stock in trade and uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 20. Nov. 1998 Geliefert am 03. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Mai 1996 Geliefert am 18. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a confidential invoice discount agreement of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 07. Nov. 1995 Geliefert am 13. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Mai 1995 Geliefert am 13. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a factoring agreement leasing agreement or otherwise on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0