RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED

RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03003291
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    • (7499) /
    • (9999) /

    Wo befindet sich RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    No 1 Dorset Street
    Southampton
    SO15 2DP
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HIGHCARE GROUP LIMITED14. Dez. 199414. Dez. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Dez. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Juni 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Dez. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Juni 2009

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten288c

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Dez. 2008

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    9 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2005

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LUCK, Richard Nigel
    North Street
    Winkfield
    SL4 4TE Windsor
    The Mouse House
    Berks
    Sekretär
    North Street
    Winkfield
    SL4 4TE Windsor
    The Mouse House
    Berks
    British61070930002
    KING, Christopher
    53 Kings Road
    TW10 6EG Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    53 Kings Road
    TW10 6EG Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish77423330002
    ELLIOT, Colin David
    17 St Anns Terrace
    NW8 6PH London
    Sekretär
    17 St Anns Terrace
    NW8 6PH London
    British104177230001
    GIDDINGS, Barry Stephen
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    Sekretär
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    British36687570001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1, 3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Sekretär
    Flat 1, 3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British96974070001
    MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    British73852970001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Sekretär
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    ELLIOT, Colin David
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    Geschäftsführer
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    British84492240002
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Geschäftsführer
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    GIDDINGS, Barry Stephen
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish36687570001
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Geschäftsführer
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Geschäftsführer
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    MUIR, Alan Morton, Doctor
    Hunters Ride
    RG20 7AX West Ilsley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Hunters Ride
    RG20 7AX West Ilsley
    Berkshire
    British105360740001
    SAVAGE, Andrew
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    Geschäftsführer
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    EnglandBritish117869550001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Geschäftsführer
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002
    STOREY, Roger Christopher
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish1663050001
    WHITEHEAD, Ronald James
    8 The Grazings
    HP2 5JN Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 The Grazings
    HP2 5JN Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritish7505760001
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    76 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Geschäftsführer
    76 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    94774980001

    Hat RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    General mortgage debenture
    Erstellt am 25. Aug. 2004
    Geliefert am 07. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a drummuir 9-11 northfield bridgwater somerset t/no ST201599, f/h property k/a mountwood nursing homes 11 & 11A millway road andover hampshire t/no HP347382, f/h property k/a hazelhurst 23 kings road horsham west sussex t/no WSX184054 (for further details of mortgaged properties please see schedule to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Aug. 2004
    Geliefert am 07. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a drummuir 9-11 northfield bridgwater somerset t/no ST201599, f/h property k/a mountwood nursing homes 11 & 11A millway road andover hampshire t/no HP347382, f/h property k/a hazelhurst 23 kings road horsham west sussex t/no WSX184054 (for further details of mortgaged properties please see schedule to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 22. Mai 2002
    Geliefert am 07. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge its rights title interest and benefit in the cash deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 07. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General mortgage debenture
    Erstellt am 22. Mai 2002
    Geliefert am 25. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./Nv
    Transaktionen
    • 25. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Mai 2002
    Geliefert am 25. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Various properties as specified on form 395 relative to the charge headed by freehold property known as drummuir 9-11 northfield bridgwater somerset TA6 7EZ title number ST201599 freehold property known as mountwood nursing home 11 & 11A millway road andover hampshire SP10 3EU title number SP347382. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.a/Nv
    Transaktionen
    • 25. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2002
    Geliefert am 09. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the trustee and the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Drummuir, 9-11 northfield, bridgwater, somerset, TA6 7EZ. Mountwood nursing home, 11 millway road, andover, hampshire, SP10 3EU. Hazelhurst, 23 kings road, horsham, west sussex, RH16 5PP. (For further property charged refer to 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Graphite Capital Management Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Juni 1998
    Geliefert am 06. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as fairfield manor & fairfield court fairfield road broadstairs kent. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Juni 1997
    Geliefert am 07. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a la div nursing home leadon court thornhill cwmbran torfaen wales t/no: WA337792. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Juni 1997
    Geliefert am 13. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a davidson house cerne abbas dorset.t/no.DT192565. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 1997
    Geliefert am 04. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a highfield nursing home bekesbourne lane bekesbourne canterbury kent t/n's K553893, K167051 and K705018 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 14. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a hazelhurst 23 kings road horsham west sussex t/no;-WSX184054 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 14. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a birchwood grove 64 and 66 sydney road haywards heath west sussex t/no;- WSX111308 and WSX111304 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Dez. 1995
    Geliefert am 13. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a drummuir nursing home 9-11 northfield bridgwater somerset and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Dez. 1995
    Geliefert am 13. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a st margarets nursing home 36 northfield bridgwater somerset and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 1995
    Geliefert am 03. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a mountwood nursing home 11 & 11A millway road andover hampshire t/n HP347382 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 24. Jan. 1995
    Geliefert am 27. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Dez. 2007Beginn der Liquidation
    08. Juni 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Robert Whiteley Smith
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praktiker
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Andrew David Conquest
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praktiker
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0