BF REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBF REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03007384
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BF REALISATIONS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich BF REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hallam Fields Road
    Ilkeston
    DE7 4AZ Derbyshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BF REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BEAUVALE FURNISHINGS LIMITED26. Mai 199526. Mai 1995
    SHOWHIDE LIMITED09. Jan. 199509. Jan. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BF REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2000

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BF REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BF REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 31. Aug. 2011

    3 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. Mai 2011

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. Mai 2010

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. Mai 2009

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. Mai 2008

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    legacy

    1 Seiten405(1)

    Verschiedenes

    Form 3.2 - statement of affairs
    4 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    9 Seiten3.10

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed beauvale furnishings LIMITED\certificate issued on 07/08/02
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    7 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return18. Jan. 2002

    legacy

    363(287)

    legacy

    5 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von BF REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STONE, Robert Eric
    Cheveral
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Cheveral
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    BritishDirector28071870002
    BRANDT, Michael Roger
    2 Dovedale Road
    West Bridgford
    NG2 6JA Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Dovedale Road
    West Bridgford
    NG2 6JA Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector14407540001
    CARTER, Sandra Pauline
    34 Nursery Hollow
    DE7 4LQ Ilkeston
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    34 Nursery Hollow
    DE7 4LQ Ilkeston
    Derbyshire
    BritishDirector75845440001
    STONE, Robert Eric
    Cheveral
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Cheveral
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    BritishDirector28071870002
    GASTER, David
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    Sekretär
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    BritishDirector80205980001
    KEELY, Terence
    Fountain Dale House
    Fountain Dale Ricket Lane
    NG21 0ND Blidworth
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Fountain Dale House
    Fountain Dale Ricket Lane
    NG21 0ND Blidworth
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director14916610005
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    GASTER, David
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    Geschäftsführer
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    BritishDirector80205980001
    KEELY, Terence
    Fountain Dale House
    Fountain Dale Ricket Lane
    NG21 0ND Blidworth
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Fountain Dale House
    Fountain Dale Ricket Lane
    NG21 0ND Blidworth
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director14916610005
    MILLERSHIP, Paul Anthony
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    BritishCompany Director14916600001
    SUTTON, Peter Arthur
    Ians Oak
    Yeldersley
    DE6 1LS Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Ians Oak
    Yeldersley
    DE6 1LS Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector79597860001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat BF REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of rectification of a debenture of 17 july 1998 and
    Erstellt am 22. Aug. 2001
    Geliefert am 30. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursaunt to a guarantee dated 17 july 1998
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Paul Anthony Millership
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1998
    Geliefert am 29. Juli 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Anthony Millership
    Transaktionen
    • 29. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1998
    Geliefert am 28. Juli 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank Investments Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 23. Apr. 1998
    Geliefert am 01. Mai 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the agent, the overdraft bank, the banks and the swap counterparties (as each term is defined in facilities agreement) and as agent pursuant to the facilities agreement) under the terms of the facilities agreement dated 23RD april 1998
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2002Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 28. Juni 2003Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
    • 28. Juni 2003Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 19. Juli 2005Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
    • 113. Sept. 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 23. Apr. 1998
    Geliefert am 01. Mai 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the agent, the overdraft bank, the banks and the swap counterparties (as each term is defined in facilities agreement) and as agent pursuant to the facilities agreement) under the terms of the facilities agreement dated 23RD april 1998
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings on the north east side of hallam fields road ilkeston derbyshire, factory premises and 2.5 acres of land at manners avenue ilkeston,. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 1995
    Geliefert am 07. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company,previously known as showhide limited,to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold land/blds on the north east side of hallam fields rd,ilkeston,derbyshire..............goodwill of business and benefit of all licences.......................see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 06. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Mai 1995
    Geliefert am 01. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as showhide limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 1995
    Geliefert am 01. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as showhide limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as 87 kingston avenue,ilkeston,derbyshire.t/nos.dy 179735 and dy 189518 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BF REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Apr. 1998Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lynn Robert Bailey
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    Praktiker
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    Stuart David Maddison
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    Praktiker
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    Am Grove
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0