BSL REALISATIONS 2011 LIMITED

BSL REALISATIONS 2011 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBSL REALISATIONS 2011 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03007892
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BSL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    • (4525) /

    Wo befindet sich BSL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BSL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LOLLIPOP SCAFFOLDING LIMITED21. Juli 201121. Juli 2011
    BENCHMARK SCAFFOLDING LIMITED09. Jan. 199509. Jan. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BSL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für BSL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    23 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2021

    19 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2020

    19 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    11 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2019

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2018

    19 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    6 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2017

    17 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    5 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2015

    13 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Apr. 2014

    12 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 25 Moorgate London EC2R 6AY* am 09. Juli 2013

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Apr. 2013

    16 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. März 2013

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Sept. 2012

    14 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Aug. 2012

    16 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Jan. 2012

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    44 Seiten2.23B

    Wer sind die Geschäftsführer von BSL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JOHNSON, Jeffrey Nicholas
    47 Lionel Road
    TW8 9QZ Brentford
    Middlesex
    Sekretär
    47 Lionel Road
    TW8 9QZ Brentford
    Middlesex
    BritishChartered Accountant6047800003
    WEST, Susan
    9 Windmill Way
    RH2 0JB Reigate
    Surrey
    Sekretär
    9 Windmill Way
    RH2 0JB Reigate
    Surrey
    BritishConatract Scaffolding41681270002
    EGGLESTON, Cain
    3 St Andrews Way
    Ardsley
    S71 5DB Barnsley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 St Andrews Way
    Ardsley
    S71 5DB Barnsley
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCommercial Director109777170001
    MCDERMOTT, Bernard Joseph
    3 The Avenue
    Ickenham
    UB10 8NR Uxbridge
    Middlesex
    Geschäftsführer
    3 The Avenue
    Ickenham
    UB10 8NR Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomIrishBuilder20593410001
    POPE, Graham
    29 Lower Road
    WD3 5LQ Chorleywood
    Flat 1 Marston Cottage
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    29 Lower Road
    WD3 5LQ Chorleywood
    Flat 1 Marston Cottage
    Hertfordshire
    United KingdomBritishNone148123810001
    SLIGHT, Keith Malcolm
    17 Stoke Road
    KT12 3DF Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    17 Stoke Road
    KT12 3DF Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritishContract Scaffolding56261670001
    TAYLOR, Paul David Stanley
    Flat 5 Stoneyleigh Court
    Western Street
    S70 2BP Huddersfield Road
    Barnsley South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Flat 5 Stoneyleigh Court
    Western Street
    S70 2BP Huddersfield Road
    Barnsley South Yorkshire
    United KingdomBritishContract Scaffolding56261650002
    WALTON, John Frederick
    5 Conifer Close
    EN7 6EY Cheshunt
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Conifer Close
    EN7 6EY Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritishContract Scaffolding37284340001
    WEST, Robert John
    9 Windmill Way
    RH2 0JB Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    9 Windmill Way
    RH2 0JB Reigate
    Surrey
    EnglandBritishContract Scaffolding41681160002
    YOUNG, Robert
    17 Craddocks Avenue
    KT21 1PA Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    17 Craddocks Avenue
    KT21 1PA Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishEngineer95060940001
    STERLING, John David
    52 Vicarage Lane
    WD4 9HR Kings Langley
    Hertfordshire
    Sekretär
    52 Vicarage Lane
    WD4 9HR Kings Langley
    Hertfordshire
    British62099670001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MACKAY, Gavin Hugh
    49 Alexandria Road
    W13 0NR London
    Geschäftsführer
    49 Alexandria Road
    W13 0NR London
    BritishContract Scaffolding65825330001
    WEST, Susan
    34 Shirley Avenue
    RH1 5AJ Redhill
    Surrey
    Geschäftsführer
    34 Shirley Avenue
    RH1 5AJ Redhill
    Surrey
    BritishConatract Scaffolding41681270001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat BSL REALISATIONS 2011 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fee agreement second charge
    Erstellt am 20. Juli 2010
    Geliefert am 23. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 10A the waterside trading centre trumpers way london unit 31 the waterside trading centre trumpers way london & units 1 32 land and parking spaces waterside trading centre trumpers way hanwell ealing t/no AGL166203 AGL51767 AGL47228 & AGL56249 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • West Register (Investments) Limited
    Transaktionen
    • 23. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Dez. 2007
    Geliefert am 14. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the north east side of valley road wombwell barnsley south yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 02. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 1 31/32 waterside trading centre trumpers way hanwell,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 02. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 10 waterside trading centre trumpters way hanwell. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 02. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north east side of valley road wombwell barnsley (max darby house),. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Sept. 2007
    Geliefert am 28. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 2007
    Geliefert am 02. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 10 waterside trading centre trumpers way hanwell. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Juni 2005
    Geliefert am 09. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land on the north east side of valley road wombwell barnsley t/n SYK41185. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 09. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Insurance premium
    Erstellt am 17. Apr. 2003
    Geliefert am 26. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies that may become payable in respect of the insurance policies being lloyds of london policy numbers 03LFPN02644 employers liability, 03LFPN02644 public products liability, CARF60 contractors all risks.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. März 2003
    Geliefert am 26. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as units 1, 32 yard and parking areas waterside trading estate trumpers way hanwell title number ACL56249. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 26. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Juni 2002
    Geliefert am 08. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a unit 31 waterside trading estate trumpers way hanwell london W7 t/n AGL47228 and AGL51767. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 2000
    Geliefert am 01. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 42 standen ave,camphill,isle of wight; t/no IW15792; all buildings fixtures fixed plant machinery and equipment thereon; all right,title and interest in and to the proceeds of any insurances and goodwill of business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Nov. 1997
    Geliefert am 17. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £222,000 due or to become due from the company to the chargee in accordance with the terms of a facility letter dated 13TH august 1997
    Kurze Angaben
    32A glenfield road ealing london W13 by way of specific charge the goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 21. Apr. 1997
    Geliefert am 24. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 x volvo 2 axle rigid body flat lorry reg. F107 nkl chassis no. YB1E6A2A1J8427565; 1 x ford 2 axle rigid flat lorry reg. G918 blp chassis no. SBCCXXCCDCLS32696; 1 x mercedes 2 x axle rigid flat lorry reg. H544 pwj chassis no. 61701825374640; 1 x mercedes 2X axle rigid flat lorry reg. J78 wjn chassis no. SBCCXXCCDCMP44138, new scaffolding equipment as per the schedule attached to form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 24. Mai 1996
    Geliefert am 29. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks Plcas Trustee for Itself and Aib Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BSL REALISATIONS 2011 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Juli 2011Beginn der Verwaltung
    04. Apr. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony Cliff Spicer
    Smith & Williamson Limited
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Praktiker
    Smith & Williamson Limited
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Henry Anthony Shinners
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Praktiker
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    2
    DatumTyp
    04. Apr. 2013Beginn der Liquidation
    27. Juli 2022Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dominic Dumville
    Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Praktiker
    Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Nicholas W Nicholson
    Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Praktiker
    Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Richard A J Hooper
    Haslers Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Praktiker
    Haslers Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Stratford Hamilton
    Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Praktiker
    Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0