D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03008724 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6th Floor 33 Holborn EC1N 2HT London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BERIA LIMITED | 11. Jan. 1995 | 11. Jan. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Woodall am 30. Juli 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Godalming Business Centre Woolsack Way Godalming Surrey GU7 1XW zum 6th Floor 33 Holborn London EC1N 2HT am 31. Mai 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2013 bis 30. Sept. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Asset Management Solutions Limited als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Beif Ii Corporate Services Limited als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Mcclatchey als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ernest Battey als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Livingston als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von International Administration Group (Guernsey) Limited als Sekretär | 3 Seiten | AP04 | ||||||||||
Ernennung von Iag Limited als Direktor | 3 Seiten | AP02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL ADMINISTRATION GROUP (GUERNSEY) LIMITED | Sekretär | Glategny Esplanade GY1 1WW St Peter Port Regency Court Guernsey Guernsey |
| 123212890003 | ||||||||||||||
| WOODALL, Mark Andrew | Geschäftsführer | Glategny Esplanade GY1 1WW St Peter Port Regency Court Guernsey Guernsey | Guernsey | British | 179218860001 | |||||||||||||
| IAG LIMITED | Geschäftsführer | Glategny Esplanade GY1 1WW St Peter Port Regency Court Guernsey Guernsey |
| 171273930001 | ||||||||||||||
| FAY, Martin Lawrence | Sekretär | Crofton Cliff Crofton Avenue PO13 9NJ Lee On The Solent Hampshire | British | 8066790001 | ||||||||||||||
| JOHNSTON, William Raymond | Sekretär | 9 Beverley Court 59 Fairfax Road NW6 4EG London | British | 37227240001 | ||||||||||||||
| NETTLESHIP, Isobel Mary | Sekretär | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | 147086990001 | ||||||||||||||
| SHERIDAN, Clare | Sekretär | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | 74216410002 | ||||||||||||||
| ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | Sekretär | Charles Street CF10 2GE Cardiff 46 United Kingdom |
| 166036180001 | ||||||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||||||
| BATTEY, Ernest Stephen | Geschäftsführer | Furnival Street EC4A 1AB London 10 United Kingdom | British | 28614660001 | ||||||||||||||
| BENNETT, Nigel Anthony | Geschäftsführer | 7 Courtneidge Close LU7 0EL Stewkley Bedfordshire | England | British | 74375610001 | |||||||||||||
| BISHOP, John Michael | Geschäftsführer | Orchard View Tintells Lane KT24 6JD West Horsley Surrey | England | British | 116243840001 | |||||||||||||
| BURGESS, Richard John | Geschäftsführer | 54 Manor Road SM2 7AG Cheam Surrey | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 35427700001 | |||||||||||||
| DIXON, Richard John | Geschäftsführer | Furnival Street EC4A 1AB London 10 | United Kingdom | British | 130277830002 | |||||||||||||
| EMINSON, Clive Franklin | Geschäftsführer | Garden Cottage Stratton Hall Lane Levington IP10 0LH Ipswich Suffolk | England | British | 39767370001 | |||||||||||||
| FAY, Linda Diane Isabel | Geschäftsführer | Crofton Cliff Crofton Avenue PO13 9NJ Lee On The Solent Hampshire | British | 38454870001 | ||||||||||||||
| FAY, Martin Lawrence | Geschäftsführer | Crofton Cliff Crofton Avenue PO13 9NJ Lee On The Solent Hampshire | British | 8066790001 | ||||||||||||||
| HARTSHORN, Timothy | Geschäftsführer | 5 Freston Road N3 1UP London | British | 103668910001 | ||||||||||||||
| KEITH, Alistair | Geschäftsführer | Wildacre South Munstead Lane GU8 4AG Godalming Surrey | British | 69099040002 | ||||||||||||||
| LIVINGSTON, Andrew James | Geschäftsführer | Furnival Street EC4A 1AB London 10 United Kingdom | England | British | 132011640001 | |||||||||||||
| MCCLATCHEY, Robert Sean | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc | United Kingdom | British | 140441450001 | |||||||||||||
| STYLES, Robert James | Geschäftsführer | 7 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 102666050001 | |||||||||||||
| TASKER, Ian James | Geschäftsführer | 26 Ravensbourne Avenue BR2 0BP Bromley Kent | England | British | 84496470004 | |||||||||||||
| BEIF II CORPORATE SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 100 Wood Street EC2V 7EX London Fifth Floor United Kingdom |
| 151210770001 | ||||||||||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicx Fund Limited | 06. Apr. 2016 | Glategny Esplanade St. Peter Port GY1 1WW Guernsey Regency Court Channel Islands | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of legal charge | Erstellt am 25. Jan. 2000 Geliefert am 27. Jan. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from primary medical property limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary medical property limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 49 portsmouth rd woolston southampton, land and buildings on the south east side of beaulieu rd dibden purlieu southampton and briar cottage beaulieu rd dibden together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of charge | Erstellt am 20. Dez. 1999 Geliefert am 30. Dez. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from primary medical properties investments limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary medical properties investments limited on any account whatsoever and in any manner whatsoever to the general practice finance corporation limited under the provisions of the deed of legal charge dated 20TH december 1999 | |
Kurze Angaben All rights titles and interests and whether present or future of the compny the occupational leases in respect of the property at 49 portsmouth road woolston southampton and at beaulieu road dibden purlieu southampton. All sums due by way of insurance rent. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 20. Dez. 1999 Geliefert am 30. Dez. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £2,304,457.00 owed by primary medical investments limited together with interest thereon pursuant to the provisions of the legal charge and all monies laid out by the general practice finance corporation limited under any of the provisions of the legal charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a 49 portsmouth road woolston southampton together with fixtures and fittings and equipment and all f/h property at beaulieu road dibden purlieu southampton. Floating charge all undertakings property assets and rights present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Sept. 1998 Geliefert am 05. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 49 portsmouth road woolston southampton hampshire t/no;-HP469177. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0