CHERUB HOTELS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHERUB HOTELS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03016137
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHERUB HOTELS LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich CHERUB HOTELS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    198 High Street
    Burbage
    SN8 3AB Marlborough
    Wiltshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CHERUB HOTELS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ARCHQUOTE LIMITED30. Jan. 199530. Jan. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHERUB HOTELS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CHERUB HOTELS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHERUB HOTELS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 11,028
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2013

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 12. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 11,028
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Webb am 28. Jan. 2014

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Angel Hotel North Street Midhurst West Sussex GU29 9DN United Kingdom* am 12. Feb. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2012

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2011

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Tudor View, North Street Midhurst West Sussex GU29 9DJ* am 21. Feb. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2010

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Martin Cleaton Powell am 30. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Webb am 30. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 25. Nov. 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von CHERUB HOTELS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BREW, Godfrey Arthur
    Plum Tree Cottage
    High Street
    SN8 3AB Burbage
    Wiltshire
    Sekretär
    Plum Tree Cottage
    High Street
    SN8 3AB Burbage
    Wiltshire
    British83362410001
    POWELL, David Martin Cleaton
    Broughtons 26 Greenacres
    Birdham
    PO20 7HL Chichester
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Broughtons 26 Greenacres
    Birdham
    PO20 7HL Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish10175760007
    WEBB, Ian Paul
    Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    33
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    33
    Surrey
    England
    United KingdomBritish93562530003
    COOPER, Ian Richard
    The Cottage
    Beavers Hill
    GU9 7DF Farnham
    Surrey
    Sekretär
    The Cottage
    Beavers Hill
    GU9 7DF Farnham
    Surrey
    British86448820001
    DAVIES, Nicholas Clive
    The Angel Hotel
    Tudor View North Street
    GU29 9DN Midhurst
    West Sussex
    Sekretär
    The Angel Hotel
    Tudor View North Street
    GU29 9DN Midhurst
    West Sussex
    British42626630001
    SIXSMITH, John Stephen
    7 Manor Close
    Felpham
    PO22 7PN Bognor Regis
    West Sussex
    Sekretär
    7 Manor Close
    Felpham
    PO22 7PN Bognor Regis
    West Sussex
    British36871040001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CARMINGER, Lars Ivar Pontus
    Offham House
    Offham
    BN7 3QE Lewes
    Sussex
    Geschäftsführer
    Offham House
    Offham
    BN7 3QE Lewes
    Sussex
    United KingdomSwedish58659610001
    CARMINGER, Miranda Anne
    Offham House
    Offham
    BN7 3QE Lewes
    Sussex
    Geschäftsführer
    Offham House
    Offham
    BN7 3QE Lewes
    Sussex
    United KingdomBritish30020440002
    COOPER, Ian Richard
    The Cottage
    Beavers Hill
    GU9 7DF Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Cottage
    Beavers Hill
    GU9 7DF Farnham
    Surrey
    British86448820001
    COOPER, John Richard
    Squirrels Leap
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Squirrels Leap
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hampshire
    British84194850001
    CRAWFORD-ROLT, Peter
    The Angel Hotel
    Tudor View North Street
    GU29 9DN Midhurst
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Angel Hotel
    Tudor View North Street
    GU29 9DN Midhurst
    West Sussex
    British69329090001
    DAVIES, Michael Hartley
    Ui Fabryczna
    16/22 M53
    00446 Warsaw
    Poland
    Geschäftsführer
    Ui Fabryczna
    16/22 M53
    00446 Warsaw
    Poland
    British37351900003
    DAVIES, Nicholas Clive
    The Angel Hotel
    Tudor View North Street
    GU29 9DN Midhurst
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Angel Hotel
    Tudor View North Street
    GU29 9DN Midhurst
    West Sussex
    British42626630001
    GOODMAN, Anne Elizabeth
    Offham House
    Offham
    BN7 3QE Lewes
    Sussex
    Geschäftsführer
    Offham House
    Offham
    BN7 3QE Lewes
    Sussex
    British19705310001
    GOODMAN, Howard Neville Alexander
    Offham House
    Offham
    BN7 3QE Lewes
    Sussex
    Geschäftsführer
    Offham House
    Offham
    BN7 3QE Lewes
    Sussex
    EnglandBritish30020410001
    HUDSON, Douglas Edward Clark
    Holdfast Cottage Holdfast Lane
    GU27 2EY Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Holdfast Cottage Holdfast Lane
    GU27 2EY Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish3274230001
    SIXSMITH, John Stephen
    7 Manor Close
    Felpham
    PO22 7PN Bognor Regis
    West Sussex
    Geschäftsführer
    7 Manor Close
    Felpham
    PO22 7PN Bognor Regis
    West Sussex
    United KingdomBritish36871040001
    THORNE, James Henry
    18 Three Stiles Road
    GU9 7DE Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    18 Three Stiles Road
    GU9 7DE Farnham
    Surrey
    EnglandBritish61046160001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Hat CHERUB HOTELS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. Aug. 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2004
    Geliefert am 06. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as the angel hotel and tudor cottage north street midhurst west sussex t/n WSX169554.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the angel hotel north street midhurst west sussex t/no: WSX169554. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Apr. 1999
    Geliefert am 17. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H tudor view north street midhurst west sussex-WSX168813. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Erstellt am 29. März 1999
    Geliefert am 13. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from offham hotels limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as the angel hotel,north st,midhurst,west sussex GU29 9DN; t/no WSX169544. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Erstellt am 29. März 1999
    Geliefert am 13. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from offham hotels limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as the rother inn,lutener rd,easebourne,midhurst,west sussex GU29 9AT; wsx 195335. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 29. März 1999
    Geliefert am 07. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Juli 1997
    Geliefert am 08. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as the cathedral hotel,milford st,salisbury wiltshire; wt 107164; the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 08. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 01. Apr. 1997
    Geliefert am 11. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cathedral hotel milford street salisbury t/no;-WT107164 together with all buildings and fixtures (inc.trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon all future book and other debts all rental and other monies all goodwill of any business at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 06. Okt. 1995
    Geliefert am 07. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the angel hotel north street midhurst t/n wsx 169554. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks Plcas Security for Itself and/or Aib Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1992
    Erworben am 06. Okt. 1995
    Geliefert am 11. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000
    Kurze Angaben
    The angel hotel north street midhurst west sussex.
    Berechtigte Personen
    • George Gale & Company Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1995Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 09. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0