CHERUB HOTELS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHERUB HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03016137 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHERUB HOTELS LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich CHERUB HOTELS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 198 High Street Burbage SN8 3AB Marlborough Wiltshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHERUB HOTELS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ARCHQUOTE LIMITED | 30. Jan. 1995 | 30. Jan. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHERUB HOTELS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CHERUB HOTELS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CHERUB HOTELS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Webb am 28. Jan. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Angel Hotel North Street Midhurst West Sussex GU29 9DN United Kingdom* am 12. Feb. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Tudor View, North Street Midhurst West Sussex GU29 9DJ* am 21. Feb. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Martin Cleaton Powell am 30. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Webb am 30. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 25. Nov. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHERUB HOTELS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREW, Godfrey Arthur | Sekretär | Plum Tree Cottage High Street SN8 3AB Burbage Wiltshire | British | 83362410001 | ||||||
| POWELL, David Martin Cleaton | Geschäftsführer | Broughtons 26 Greenacres Birdham PO20 7HL Chichester West Sussex | England | British | 10175760007 | |||||
| WEBB, Ian Paul | Geschäftsführer | Shortheath Crest GU9 8SB Farnham 33 Surrey England | United Kingdom | British | 93562530003 | |||||
| COOPER, Ian Richard | Sekretär | The Cottage Beavers Hill GU9 7DF Farnham Surrey | British | 86448820001 | ||||||
| DAVIES, Nicholas Clive | Sekretär | The Angel Hotel Tudor View North Street GU29 9DN Midhurst West Sussex | British | 42626630001 | ||||||
| SIXSMITH, John Stephen | Sekretär | 7 Manor Close Felpham PO22 7PN Bognor Regis West Sussex | British | 36871040001 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| CARMINGER, Lars Ivar Pontus | Geschäftsführer | Offham House Offham BN7 3QE Lewes Sussex | United Kingdom | Swedish | 58659610001 | |||||
| CARMINGER, Miranda Anne | Geschäftsführer | Offham House Offham BN7 3QE Lewes Sussex | United Kingdom | British | 30020440002 | |||||
| COOPER, Ian Richard | Geschäftsführer | The Cottage Beavers Hill GU9 7DF Farnham Surrey | British | 86448820001 | ||||||
| COOPER, John Richard | Geschäftsführer | Squirrels Leap Queen Mary Close GU51 4QR Fleet Hampshire | British | 84194850001 | ||||||
| CRAWFORD-ROLT, Peter | Geschäftsführer | The Angel Hotel Tudor View North Street GU29 9DN Midhurst West Sussex | British | 69329090001 | ||||||
| DAVIES, Michael Hartley | Geschäftsführer | Ui Fabryczna 16/22 M53 00446 Warsaw Poland | British | 37351900003 | ||||||
| DAVIES, Nicholas Clive | Geschäftsführer | The Angel Hotel Tudor View North Street GU29 9DN Midhurst West Sussex | British | 42626630001 | ||||||
| GOODMAN, Anne Elizabeth | Geschäftsführer | Offham House Offham BN7 3QE Lewes Sussex | British | 19705310001 | ||||||
| GOODMAN, Howard Neville Alexander | Geschäftsführer | Offham House Offham BN7 3QE Lewes Sussex | England | British | 30020410001 | |||||
| HUDSON, Douglas Edward Clark | Geschäftsführer | Holdfast Cottage Holdfast Lane GU27 2EY Haslemere Surrey | England | British | 3274230001 | |||||
| SIXSMITH, John Stephen | Geschäftsführer | 7 Manor Close Felpham PO22 7PN Bognor Regis West Sussex | United Kingdom | British | 36871040001 | |||||
| THORNE, James Henry | Geschäftsführer | 18 Three Stiles Road GU9 7DE Farnham Surrey | England | British | 61046160001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Hat CHERUB HOTELS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Aug. 2004 Geliefert am 11. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Aug. 2004 Geliefert am 06. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as the angel hotel and tudor cottage north street midhurst west sussex t/n WSX169554. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Sept. 2002 Geliefert am 10. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Sept. 2002 Geliefert am 10. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the angel hotel north street midhurst west sussex t/no: WSX169554. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Apr. 1999 Geliefert am 17. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H tudor view north street midhurst west sussex-WSX168813. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge containing fixed and floating charges | Erstellt am 29. März 1999 Geliefert am 13. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from offham hotels limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as the angel hotel,north st,midhurst,west sussex GU29 9DN; t/no WSX169544. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge containing fixed and floating charges | Erstellt am 29. März 1999 Geliefert am 13. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from offham hotels limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as the rother inn,lutener rd,easebourne,midhurst,west sussex GU29 9AT; wsx 195335. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 29. März 1999 Geliefert am 07. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Juli 1997 Geliefert am 08. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as the cathedral hotel,milford st,salisbury wiltshire; wt 107164; the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 01. Apr. 1997 Geliefert am 11. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Cathedral hotel milford street salisbury t/no;-WT107164 together with all buildings and fixtures (inc.trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon all future book and other debts all rental and other monies all goodwill of any business at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 06. Okt. 1995 Geliefert am 07. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H the angel hotel north street midhurst t/n wsx 169554. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1992 Erworben am 06. Okt. 1995 Geliefert am 11. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 | |
Kurze Angaben The angel hotel north street midhurst west sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0