GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED

GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03020221
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o R P RENDLE & CO LIMITED
    9 Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    West Midlands
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LANDMARK CARE FACILITIES LIMITED21. Feb. 200221. Feb. 2002
    COMMUNITY DEVELOPMENTS LIMITED30. Apr. 199830. Apr. 1998
    STOPPA LIMITED17. Nov. 199517. Nov. 1995
    MARKETEL LIMITED09. Feb. 199509. Feb. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Dez. 2013

    14 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    15 Seiten4.71

    Bescheinigung, dass die Gläubiger vollständig bezahlt wurden

    2 Seiten4.51

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor 3-5 Swallow Place London W1B 2AF* am 06. Dez. 2012

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Anton David Curtis am 11. Okt. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Anton David Curtis am 11. Okt. 2012

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Ungelson am 08. Okt. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. März 2012

    Kapitalaufstellung am 08. März 2012

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 12-14 St Christopher's Place London W1U 1NB* am 25. Feb. 2010

    2 SeitenAD01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2009 bis 31. Dez. 2009

    3 SeitenAA01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CURTIS, Anton David
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    British115446010001
    CURTIS, Anton David
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish151245590002
    UNGELSON, Jeremy
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish125304300002
    CLARKE, Rachel Ann
    5 Longridge Avenue
    NE7 7LB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    5 Longridge Avenue
    NE7 7LB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British81840100001
    FRANCIS, Hugh
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    Sekretär
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    English40354440003
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Sekretär
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    British143242660001
    MCCAFFERTY, Mark John
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    British81370550001
    MCLEISH, William David
    26 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JX Paisley
    Renfrewshire
    Sekretär
    26 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JX Paisley
    Renfrewshire
    British168970640001
    MICHELSON, Allan Denis
    33 North Avenue
    Gosforth
    NE3 4DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    33 North Avenue
    Gosforth
    NE3 4DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British13305820001
    MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    British73852970001
    RILEY, Michelle
    2 Camberwell Close
    NE11 9TZ Gateshead
    Tyne & Wear
    Sekretär
    2 Camberwell Close
    NE11 9TZ Gateshead
    Tyne & Wear
    British52057290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FRANCIS, Hugh
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    Geschäftsführer
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    EnglandEnglish40354440003
    LEWIS, Gary Owen
    Mount Farm
    Eighton Banks
    NE9 7YP Gateshead
    Geschäftsführer
    Mount Farm
    Eighton Banks
    NE9 7YP Gateshead
    British51006650004
    LEWIS, Gary Owen
    Valemount Eighton Banks
    NE9 7YL Gateshead
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Valemount Eighton Banks
    NE9 7YL Gateshead
    Tyne & Wear
    British51006650001
    LEWIS, Gary Owen
    4 Larwood Court
    DH3 3QQ Chester Le Street
    County Durham
    Geschäftsführer
    4 Larwood Court
    DH3 3QQ Chester Le Street
    County Durham
    British41951370002
    LEWIS, Joanne Lynn
    17 Bewicke View
    DH3 1RU Birtley
    Geschäftsführer
    17 Bewicke View
    DH3 1RU Birtley
    British41951380004
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Geschäftsführer
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    United KingdomBritish143242660001
    MCCAFFERTY, Mark John
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    British81370550001
    MCGRATH, Kay
    23 Hazelmoor
    NE31 1DH Hebburn
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    23 Hazelmoor
    NE31 1DH Hebburn
    Tyne & Wear
    British103145700001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    STROWBRIDGE, John Michael Barrie
    Keepers Lodge
    Hollowell Reservoir Hollowell
    NN6 8RL Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Keepers Lodge
    Hollowell Reservoir Hollowell
    NN6 8RL Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish157860840001

    Hat GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of legal charge
    Erstellt am 14. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the north west side of chester row shiney row sunderland t/no TY94518 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the leases in respect of f/h land and buildings on the north west side of chester row shiney row sunderland t/no TY94518. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    An amendment and restatement deed to a debenture dated 10 march 2006 and
    Erstellt am 30. Juni 2006
    Geliefert am 17. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of They Trustee)
    • The Royal Bank of Scotland PLC, in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Thefinance Parties and Secured Parties (The Securit
    Transaktionen
    • 17. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession
    Erstellt am 02. Mai 2006
    Geliefert am 04. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee or the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Mill lodge care centre 1A moorside place bradford west yorkshire t/n WYK677390 and WYK730706, crabwall hall residential home parkgate road millington chester t/n's CH246622 CH305068 and CH334555, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Graphite Capital Management LLP
    Transaktionen
    • 04. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2006
    Geliefert am 21. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H & l/h mill lodge care centre, 1A moorside place, bradford, west yorkshire t/nos. WYK677390 and WYK730706. F/h & l/hcrabwell hall residential home, parkgate road, mollington, chester t/nos. CH2466. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr John Strowbridge (The "Trustee")
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Accession deed
    Erstellt am 11. Apr. 2006
    Geliefert am 26. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver or any other person or persons on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a grangewood care centre, chester road, shiney row, tyne and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland as Security for and on Behalf of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    • The Royal Bank of Scotland as Security for and on Behalf of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Aug. 2004
    Geliefert am 17. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Apr. 2003
    Geliefert am 19. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a former grangewood service station chester road shiney row sunderland tyne and wear t/no: TY94518.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Juni 1998
    Geliefert am 24. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land situate near radford avenue and baxter avenue kidderminster t/n-WR30985.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Juni 1998
    Geliefert am 24. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H all that parcel of land situate at pershore road selly park birmingham west midlands t/nos: WM211875 and WM519519.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Mai 2014Aufgelöst am
    12. Dez. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Paul Rendle
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    Praktiker
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0