GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03020221 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o R P RENDLE & CO LIMITED 9 Hockley Court Stratford Road Hockley Heath B94 6NW Solihull West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LANDMARK CARE FACILITIES LIMITED | 21. Feb. 2002 | 21. Feb. 2002 |
| COMMUNITY DEVELOPMENTS LIMITED | 30. Apr. 1998 | 30. Apr. 1998 |
| STOPPA LIMITED | 17. Nov. 1995 | 17. Nov. 1995 |
| MARKETEL LIMITED | 09. Feb. 1995 | 09. Feb. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Dez. 2013 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 15 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Bescheinigung, dass die Gläubiger vollständig bezahlt wurden | 2 Seiten | 4.51 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor 3-5 Swallow Place London W1B 2AF* am 06. Dez. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anton David Curtis am 11. Okt. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Anton David Curtis am 11. Okt. 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Ungelson am 08. Okt. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 12-14 St Christopher's Place London W1U 1NB* am 25. Feb. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2009 bis 31. Dez. 2009 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURTIS, Anton David | Sekretär | c/o R P Rendle & Co Limited Hockley Court Stratford Road Hockley Heath B94 6NW Solihull 9 West Midlands United Kingdom | British | 115446010001 | ||||||
| CURTIS, Anton David | Geschäftsführer | c/o R P Rendle & Co Limited Hockley Court Stratford Road Hockley Heath B94 6NW Solihull 9 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 151245590002 | |||||
| UNGELSON, Jeremy | Geschäftsführer | c/o R P Rendle & Co Limited Hockley Court Stratford Road Hockley Heath B94 6NW Solihull 9 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 125304300002 | |||||
| CLARKE, Rachel Ann | Sekretär | 5 Longridge Avenue NE7 7LB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 81840100001 | ||||||
| FRANCIS, Hugh | Sekretär | 40 Topstreet Way AL5 5TT Harpenden | English | 40354440003 | ||||||
| MATTHEWS, Ian | Sekretär | Ffordd Bryngwyn Gwernymynydd CH7 5JW Nr Mold The Croft Flintshire | British | 143242660001 | ||||||
| MCCAFFERTY, Mark John | Sekretär | 16 Gowan Terrace Jesmond NE2 2PS Newcastle Upon Tyne | British | 81370550001 | ||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | 26 Newtyle Road Ralston PA1 3JX Paisley Renfrewshire | British | 168970640001 | ||||||
| MICHELSON, Allan Denis | Sekretär | 33 North Avenue Gosforth NE3 4DQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 13305820001 | ||||||
| MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal | Sekretär | 38 Fairford Avenue LU2 7ER Luton Bedfordshire | British | 73852970001 | ||||||
| RILEY, Michelle | Sekretär | 2 Camberwell Close NE11 9TZ Gateshead Tyne & Wear | British | 52057290001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| FRANCIS, Hugh | Geschäftsführer | 40 Topstreet Way AL5 5TT Harpenden | England | English | 40354440003 | |||||
| LEWIS, Gary Owen | Geschäftsführer | Mount Farm Eighton Banks NE9 7YP Gateshead | British | 51006650004 | ||||||
| LEWIS, Gary Owen | Geschäftsführer | Valemount Eighton Banks NE9 7YL Gateshead Tyne & Wear | British | 51006650001 | ||||||
| LEWIS, Gary Owen | Geschäftsführer | 4 Larwood Court DH3 3QQ Chester Le Street County Durham | British | 41951370002 | ||||||
| LEWIS, Joanne Lynn | Geschäftsführer | 17 Bewicke View DH3 1RU Birtley | British | 41951380004 | ||||||
| MATTHEWS, Ian | Geschäftsführer | Ffordd Bryngwyn Gwernymynydd CH7 5JW Nr Mold The Croft Flintshire | United Kingdom | British | 143242660001 | |||||
| MCCAFFERTY, Mark John | Geschäftsführer | 16 Gowan Terrace Jesmond NE2 2PS Newcastle Upon Tyne | British | 81370550001 | ||||||
| MCGRATH, Kay | Geschäftsführer | 23 Hazelmoor NE31 1DH Hebburn Tyne & Wear | British | 103145700001 | ||||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | 26177180002 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| STROWBRIDGE, John Michael Barrie | Geschäftsführer | Keepers Lodge Hollowell Reservoir Hollowell NN6 8RL Northampton Northamptonshire | England | British | 157860840001 |
Hat GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of legal charge | Erstellt am 14. Nov. 2007 Geliefert am 23. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the north west side of chester row shiney row sunderland t/no TY94518 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 14. Nov. 2007 Geliefert am 23. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the leases in respect of f/h land and buildings on the north west side of chester row shiney row sunderland t/no TY94518. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An amendment and restatement deed to a debenture dated 10 march 2006 and | Erstellt am 30. Juni 2006 Geliefert am 17. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 02. Mai 2006 Geliefert am 04. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the chargee or the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Mill lodge care centre 1A moorside place bradford west yorkshire t/n WYK677390 and WYK730706, crabwall hall residential home parkgate road millington chester t/n's CH246622 CH305068 and CH334555, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 11. Apr. 2006 Geliefert am 21. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H & l/h mill lodge care centre, 1A moorside place, bradford, west yorkshire t/nos. WYK677390 and WYK730706. F/h & l/hcrabwell hall residential home, parkgate road, mollington, chester t/nos. CH2466. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession deed | Erstellt am 11. Apr. 2006 Geliefert am 26. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver or any other person or persons on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a grangewood care centre, chester road, shiney row, tyne and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Aug. 2004 Geliefert am 17. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Apr. 2003 Geliefert am 19. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a former grangewood service station chester road shiney row sunderland tyne and wear t/no: TY94518. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 23. Juni 1998 Geliefert am 24. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land situate near radford avenue and baxter avenue kidderminster t/n-WR30985.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 23. Juni 1998 Geliefert am 24. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H all that parcel of land situate at pershore road selly park birmingham west midlands t/nos: WM211875 and WM519519.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0