REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED

REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03021292
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central House
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    North Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED06. Feb. 200206. Feb. 2002
    REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED17. Dez. 200117. Dez. 2001
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED 21. Dez. 200021. Dez. 2000
    REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED14. Feb. 199514. Feb. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2020

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account be cancelled 18/11/2020
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Dean Anthony Barber als Geschäftsführer am 03. Apr. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Dean Anthony Barber als Direktor am 02. Sept. 2019

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Peter Brotherton als Sekretär am 03. Sept. 2018

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Harneet Jagpal als Sekretär am 03. Sept. 2018

    2 SeitenAP03

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Fraser St John Fisher als Geschäftsführer am 20. Okt. 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Peter James Brotherton als Direktor am 28. Nov. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Peter Brotherton als Sekretär am 28. Nov. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Coleman als Geschäftsführer am 06. Nov. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Coleman als Sekretär am 06. Nov. 2016

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAGPAL, Harneet
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Sekretär
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    250198230001
    BROTHERTON, Peter James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish116701310002
    BRACHER, Alan Richard
    53 Foley Road
    KT10 0LU Claygate
    Surrey
    Sekretär
    53 Foley Road
    KT10 0LU Claygate
    Surrey
    British36451680001
    BROTHERTON, Peter
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Sekretär
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    220552440001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Sekretär
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    210014290001
    CROFT, Estelle Louise
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Sekretär
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    195008160001
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    British88772110001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Sekretär
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    164939920001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    MYHILL, Paul Harvey
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Sekretär
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    175306270001
    O'RORKE, Nicholas
    Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre
    Oxfordshire
    Sekretär
    Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre
    Oxfordshire
    149441960001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Sekretär
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British80721980001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    BARBER, Dean Anthony
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish230739040001
    BROWN, Ian Christopher
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish75493580001
    BRUCE, Robert David Glenrinnes
    45 Gally Hill Road
    Church Crookham
    GU13 0QE Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    45 Gally Hill Road
    Church Crookham
    GU13 0QE Fleet
    Hampshire
    British66210170001
    BYAM SHAW, Justin David Elliott
    6 Westbourne Park Road
    W2 5PH London
    Geschäftsführer
    6 Westbourne Park Road
    W2 5PH London
    British40017100001
    CARRINGTON, John Christopher
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Geschäftsführer
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish79087670001
    CHATFIELD, Paul
    21 Ludlow Avenue
    WR4 0EN Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    21 Ludlow Avenue
    WR4 0EN Worcester
    Worcestershire
    British71912610001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish163698620001
    COVE, Graham Lawrence
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    EnglandBritish45340010002
    COX, David Howard
    Waverley
    Chenies Road Chorleywood
    WD3 5LU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Waverley
    Chenies Road Chorleywood
    WD3 5LU Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish100698330001
    CUSHING, Robert Sefton
    66 Columbia Place Fornham Street
    S2 4AR Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    66 Columbia Place Fornham Street
    S2 4AR Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish117325300001
    DAWSON, John Hugh
    Ashleigh
    Grenofen
    PL19 9EW Tavistock
    Devon
    Geschäftsführer
    Ashleigh
    Grenofen
    PL19 9EW Tavistock
    Devon
    EnglandBritish59251210001
    DEANE, Keith
    2 Westminster Close
    GU51 4NR Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    2 Westminster Close
    GU51 4NR Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish85309310001
    DONNELLY, Mary Kathleen
    Prospect House
    1a Prospect Row
    CB1 1DU Cambridge
    Geschäftsführer
    Prospect House
    1a Prospect Row
    CB1 1DU Cambridge
    EnglandBritish85309000001
    DOUGHTY, Royston George
    60 Cedars Road
    Hampton Wick
    KT1 4BE Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    60 Cedars Road
    Hampton Wick
    KT1 4BE Kingston Upon Thames
    Surrey
    British6194830001
    DOWNHAM, Robert Henry
    Spring Cottage
    The Common
    DT11 8QY Blandford Forum
    Dorset
    Geschäftsführer
    Spring Cottage
    The Common
    DT11 8QY Blandford Forum
    Dorset
    British98701880001
    FISHER, Fraser St John
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish72704710002
    GRAY, Christopher Robert
    15 Vale Close
    Lower Bourne
    GU10 3HR Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Vale Close
    Lower Bourne
    GU10 3HR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish23552180001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88772110001
    LANCH, Nigel Leslie
    Willow Cottage 19 Water Lane
    KT11 2PA Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Willow Cottage 19 Water Lane
    KT11 2PA Cobham
    Surrey
    British54508950001
    MCGOUGAN, Malcolm James Andrew
    33 Shrub End Road
    CO3 3UD Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    33 Shrub End Road
    CO3 3UD Colchester
    Essex
    British44066820001
    MOONEY, Jeremy
    135 Victoria Road
    N22 7XH London
    Geschäftsführer
    135 Victoria Road
    N22 7XH London
    British71912690001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Redcentric Holdings Limited
    Otley Road
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    England
    06. Apr. 2016
    Otley Road
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 20. Dez. 2013
    Geliefert am 08. Jan. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Ground floor, building no. 3 (newton house), the cambridge business park, milton road, cambridge t/no CB340008. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Group debenture
    Erstellt am 21. Juni 2012
    Geliefert am 29. Juni 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over shares
    Erstellt am 24. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the charged securities, any related rights, dividends, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 26. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed
    Erstellt am 24. Juli 2002
    Geliefert am 13. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £22,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Deposit of £22,500 and all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goodall Barnard Holdings Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 24. Juli 2002
    Geliefert am 13. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £12,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £12,500 deposit with all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goodall Barnard Holdings Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 24. Juli 2002
    Geliefert am 13. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £15,000.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £15,000 deposit and all other moneys demanded and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goodall Barnard Properties Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 09. Mai 2001
    Geliefert am 15. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease granted on the same date as the deed
    Kurze Angaben
    The deposit is defined in the deed as the sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £25,375,00 paid by the tenant under the deed, any renewal or replacement of these sums, all interest earned on the account and all entitlements, rights and benefits accruing directly or indirectly to the account.
    Berechtigte Personen
    • South Herts Office Campus Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 21. Aug. 2000
    Geliefert am 24. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the property known as third floor unit b south herts office campus borehamwood
    Kurze Angaben
    A deposit of £33,876 and accruing interest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2000
    Geliefert am 25. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the obligors to the chargee under each of the finance documents
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the equipment all benefits in respect of the insurances and all proceeds thereof for full details and definitions please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Juni 2000
    Geliefert am 18. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Kurze Angaben
    The tenant charges its interest in the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Computer Associates UK Limited
    Transaktionen
    • 18. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit
    Erstellt am 08. März 2000
    Geliefert am 28. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The sum of £61,117 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The sum. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Computer Associates UK Limited
    Transaktionen
    • 28. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit deed
    Erstellt am 16. Juli 1998
    Geliefert am 18. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The due compliance of the company's obligations with the chargee under the lease dated 16TH july 1998
    Kurze Angaben
    The sum of £27,354.25 deposited at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london together with any interest accrued.
    Berechtigte Personen
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transaktionen
    • 18. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1997
    Geliefert am 10. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 17. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Apr. 1996
    Geliefert am 25. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £482,925 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Three okeford switches.
    Berechtigte Personen
    • Planet Internet (UK) Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit deed
    Erstellt am 27. Feb. 1996
    Geliefert am 28. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 27TH february 1996
    Kurze Angaben
    Deposit of £18,175 maintained at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london tigether with all interest accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0