REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03021292 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central House Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED | 06. Feb. 2002 | 06. Feb. 2002 |
| REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED | 17. Dez. 2001 | 17. Dez. 2001 |
| REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED | 21. Dez. 2000 | 21. Dez. 2000 |
| REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED | 14. Feb. 1995 | 14. Feb. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dean Anthony Barber als Geschäftsführer am 03. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Dean Anthony Barber als Direktor am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Brotherton als Sekretär am 03. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Harneet Jagpal als Sekretär am 03. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fraser St John Fisher als Geschäftsführer am 20. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter James Brotherton als Direktor am 28. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter Brotherton als Sekretär am 28. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Coleman als Geschäftsführer am 06. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Coleman als Sekretär am 06. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGPAL, Harneet | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 250198230001 | |||||||
| BROTHERTON, Peter James | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 116701310002 | |||||
| BRACHER, Alan Richard | Sekretär | 53 Foley Road KT10 0LU Claygate Surrey | British | 36451680001 | ||||||
| BROTHERTON, Peter | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 220552440001 | |||||||
| COLEMAN, Timothy James | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 210014290001 | |||||||
| CROFT, Estelle Louise | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | 195008160001 | |||||||
| HARROLD, Alan Henry | Sekretär | Cherry Tree House The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | British | 88772110001 | ||||||
| HAYES, Peter Andrew | Sekretär | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | 164939920001 | |||||||
| HAYES, Peter Andrew | Sekretär | 2 Somersby Crescent SL6 3YY Maidenhead Berkshire | British | 66610550002 | ||||||
| MYHILL, Paul Harvey | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | 175306270001 | |||||||
| O'RORKE, Nicholas | Sekretär | Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre Oxfordshire | 149441960001 | |||||||
| VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr. | Sekretär | 7 Hawkes Leap GU20 6JL Windlesham Surrey | British | 80721980001 | ||||||
| BALAAM, Martin Anthony | Geschäftsführer | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 82233550001 | |||||
| BARBER, Dean Anthony | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 230739040001 | |||||
| BROWN, Ian Christopher | Geschäftsführer | Fox Hollow Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | England | British | 75493580001 | |||||
| BRUCE, Robert David Glenrinnes | Geschäftsführer | 45 Gally Hill Road Church Crookham GU13 0QE Fleet Hampshire | British | 66210170001 | ||||||
| BYAM SHAW, Justin David Elliott | Geschäftsführer | 6 Westbourne Park Road W2 5PH London | British | 40017100001 | ||||||
| CARRINGTON, John Christopher | Geschäftsführer | 1 Anchor Brewhouse 50 Shad Thames SE1 2LY London | United Kingdom | British | 79087670001 | |||||
| CHATFIELD, Paul | Geschäftsführer | 21 Ludlow Avenue WR4 0EN Worcester Worcestershire | British | 71912610001 | ||||||
| COLEMAN, Timothy James | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British | 163698620001 | |||||
| COVE, Graham Lawrence | Geschäftsführer | 2 White House Close SG14 3TW Watton At Stone Hertfordshire | England | British | 45340010002 | |||||
| COX, David Howard | Geschäftsführer | Waverley Chenies Road Chorleywood WD3 5LU Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 100698330001 | |||||
| CUSHING, Robert Sefton | Geschäftsführer | 66 Columbia Place Fornham Street S2 4AR Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 117325300001 | |||||
| DAWSON, John Hugh | Geschäftsführer | Ashleigh Grenofen PL19 9EW Tavistock Devon | England | British | 59251210001 | |||||
| DEANE, Keith | Geschäftsführer | 2 Westminster Close GU51 4NR Fleet Hampshire | England | British | 85309310001 | |||||
| DONNELLY, Mary Kathleen | Geschäftsführer | Prospect House 1a Prospect Row CB1 1DU Cambridge | England | British | 85309000001 | |||||
| DOUGHTY, Royston George | Geschäftsführer | 60 Cedars Road Hampton Wick KT1 4BE Kingston Upon Thames Surrey | British | 6194830001 | ||||||
| DOWNHAM, Robert Henry | Geschäftsführer | Spring Cottage The Common DT11 8QY Blandford Forum Dorset | British | 98701880001 | ||||||
| FISHER, Fraser St John | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 72704710002 | |||||
| GRAY, Christopher Robert | Geschäftsführer | 15 Vale Close Lower Bourne GU10 3HR Farnham Surrey | United Kingdom | British | 23552180001 | |||||
| HALLETT, Peter John | Geschäftsführer | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HARROLD, Alan Henry | Geschäftsführer | Cherry Tree House The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | England | British | 88772110001 | |||||
| LANCH, Nigel Leslie | Geschäftsführer | Willow Cottage 19 Water Lane KT11 2PA Cobham Surrey | British | 54508950001 | ||||||
| MCGOUGAN, Malcolm James Andrew | Geschäftsführer | 33 Shrub End Road CO3 3UD Colchester Essex | British | 44066820001 | ||||||
| MOONEY, Jeremy | Geschäftsführer | 135 Victoria Road N22 7XH London | British | 71912690001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redcentric Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Otley Road HG3 1UG Harrogate Central House England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 20. Dez. 2013 Geliefert am 08. Jan. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Ground floor, building no. 3 (newton house), the cambridge business park, milton road, cambridge t/no CB340008. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 21. Juni 2012 Geliefert am 29. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 24. Feb. 2009 Geliefert am 27. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the charged securities, any related rights, dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Okt. 2006 Geliefert am 13. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Juli 2005 Geliefert am 26. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 24. Juli 2002 Geliefert am 13. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £22,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Deposit of £22,500 and all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 24. Juli 2002 Geliefert am 13. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £12,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £12,500 deposit with all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 24. Juli 2002 Geliefert am 13. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £15,000 deposit and all other moneys demanded and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 09. Mai 2001 Geliefert am 15. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease granted on the same date as the deed | |
Kurze Angaben The deposit is defined in the deed as the sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £25,375,00 paid by the tenant under the deed, any renewal or replacement of these sums, all interest earned on the account and all entitlements, rights and benefits accruing directly or indirectly to the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 21. Aug. 2000 Geliefert am 24. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the property known as third floor unit b south herts office campus borehamwood | |
Kurze Angaben A deposit of £33,876 and accruing interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 15. Aug. 2000 Geliefert am 25. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the obligors to the chargee under each of the finance documents | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the equipment all benefits in respect of the insurances and all proceeds thereof for full details and definitions please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. Juni 2000 Geliefert am 18. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease | |
Kurze Angaben The tenant charges its interest in the deposit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit | Erstellt am 08. März 2000 Geliefert am 28. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The sum of £61,117 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The sum. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 16. Juli 1998 Geliefert am 18. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The due compliance of the company's obligations with the chargee under the lease dated 16TH july 1998 | |
Kurze Angaben The sum of £27,354.25 deposited at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london together with any interest accrued. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Sept. 1997 Geliefert am 10. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Okt. 1996 Geliefert am 17. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Apr. 1996 Geliefert am 25. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £482,925 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Three okeford switches. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 27. Feb. 1996 Geliefert am 28. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 27TH february 1996 | |
Kurze Angaben Deposit of £18,175 maintained at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london tigether with all interest accruing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0