JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03023442 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Meridian House The Crescent YO24 1AW York North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FASTLINE GROUP LTD | 19. März 1996 | 19. März 1996 |
| FASTLINE RAIL SERVICES LIMITED | 17. Feb. 1995 | 17. Feb. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 24 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Meridian House The Crescent YO24 1AW York North Yorkshire | 70053320013 | |||||||
| AKINLADE, Mark Adeyemi Asagba | Geschäftsführer | The Haven Woodview Close KT21 1HA Ashtead Surrey | England | British | 116740230002 | |||||
| LAIRD, Stuart Wilson | Geschäftsführer | Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane Horton Heath SO50 7DF Eastleigh Hampshire | England | British | 60742240002 | |||||
| THORNTON, Richard Michael | Geschäftsführer | 17 Collingwood Drive NE46 2JA Hexham Northumberland | United Kingdom | British | 98817540001 | |||||
| DOW, Andrew Richard George | Sekretär | Sycamore House Station Lane YO6 1AG Shipton-By-Beningbrough Yorkshire | British | 42333690002 | ||||||
| KENDALL, Robert William | Sekretär | 44 Moreland Drive SL9 8BD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 20374510001 | ||||||
| TEMPLES (NOMINEES) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004500001 | |||||||
| ALDERSON, David | Geschäftsführer | 40 Laburnum Grove Sunniside NE16 5LY Newcastle Upon Tyne | British | 46972350001 | ||||||
| ARMITAGE, Peter Robert | Geschäftsführer | Coach House Sycamore Lane Springwood Road HD7 2SJ Holmfirth West Yorkshire | British | 107266580001 | ||||||
| BRAZIER, Martin | Geschäftsführer | 14 Cleve Avenue Toton NG9 6JH Nottingham | England | British | 77374440002 | |||||
| BROADBENT, Noel | Geschäftsführer | 21 Kerver Lane Dunnington YO19 5SL York | England | British | 60192070001 | |||||
| CLARKE, Robert John | Geschäftsführer | Candacraig Wass YO61 4AX York North Yorkshire | United Kingdom | British | 83691100001 | |||||
| CUNNINGHAM, Anthony | Geschäftsführer | Brafferton YO61 2NZ York The Old Vicarage North Yorkshire United Kingdom | England | British | 135811090001 | |||||
| DAVIES, William Richard | Geschäftsführer | 35 Jervis Court Sutton On Derwent YO41 4JX York North Yorkshire | British | 102300730001 | ||||||
| DOGGETT, David Philip | Geschäftsführer | 2 Holly Bank Hodgson Lane Upper Poppleton YO2 6DZ York | British | 41122990001 | ||||||
| DOUGLAS, David | Geschäftsführer | The Croft Hodgson Lane, Upper Poppleton YO26 6EA York | England | British | 119255740001 | |||||
| DOW, Andrew Richard George | Geschäftsführer | Sycamore House Station Lane YO6 1AG Shipton-By-Beningbrough Yorkshire | British | 42333690002 | ||||||
| DOYLE, Robert John | Geschäftsführer | The Limes 112 Hewarth Green York North Yorkshire | British | 79420210002 | ||||||
| GORDON, Ray | Geschäftsführer | 29 Carrs Meadow Escrick YO19 6JZ York North Yorkshire | British | 102379260001 | ||||||
| HALL, Richard Gordon | Geschäftsführer | Farm Cottage Heath House BS28 4UG Wedmore Somerset | England | British | 771320001 | |||||
| HOUGHTON, Michael David | Geschäftsführer | Field House Back Lane Retford Road S81 8HB Blyth | British | 98817600002 | ||||||
| HURRELL, Stephen Glynn | Geschäftsführer | 49 Church Street Long Bennington NG23 5ES Newark Nottinghamshire | British | 50751120001 | ||||||
| HURRELL, Stephen Glynn | Geschäftsführer | 49 Church Street Long Bennington NG23 5ES Newark Nottinghamshire | British | 50751120001 | ||||||
| HYDE, Kevin Oliver | Geschäftsführer | 12 Mount Parade YO24 4AB York | British | 66509100002 | ||||||
| IVES, Charles Edmund | Geschäftsführer | 12 Church Close Wingerworth S42 6QA Chesterfield Derbyshire | British | 78691290001 | ||||||
| JOHNSON, Robert Nigel | Geschäftsführer | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | 57954340003 | |||||
| JOHNSON, Robert Nigel | Geschäftsführer | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | 57954340003 | |||||
| KEEGAN, James | Geschäftsführer | 11 Stonegate Eston TS6 9NP Middlesbrough Cleveland | United Kingdom | British | 33140110001 | |||||
| KENDALL, Robert William | Geschäftsführer | 44 Moreland Drive SL9 8BD Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 20374510001 | |||||
| LAFFERTY, Henry | Geschäftsführer | Windmill House 4 High Street MK44 1PG Sharnbrook Beds | England | British | 146249130001 | |||||
| LEE, John Philip | Geschäftsführer | 49 Usher Lane Haxby YO32 3LA York Yorkshire | British | 58410390001 | ||||||
| LEZALA, Andrew Peter | Geschäftsführer | 11 Finch Crescent Mickleover DE3 0TT Derby Derbyshire | British | 85889200001 | ||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Geschäftsführer | Downing House Lower Road SG8 0EG Croydon Royston Cambridgeshire | United Kingdom | British | 37404250003 | |||||
| MCKEEVER, Michael Stuart | Geschäftsführer | The Coach House Plainville Lane, Wigginton YO32 2RG York North Yorkshire | United Kingdom | British | 79851890002 | |||||
| MOAYEDI, Paris | Geschäftsführer | The Old House Bridge Green Duddenhoe End CB11 4XA Saffron Walden Essex | England | British | 2646590001 |
Hat JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 2006 Geliefert am 08. Aug. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1996 Geliefert am 09. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation the whole sums due to the chargee under and in terms of the facility letter from the chargee to the company dated 18TH september 1996; provided that the monies and liabilities which the company hereby covenants to pay and discharge shall not include any monies and liabilities arising under a regulate consumer credit agreement falling within part v of the consumer credit act 1974, unless specifically agreed in writing between the company and the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 23. Mai 1996 Geliefert am 05. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement and/or any hedging agreement (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of key-man policy | Erstellt am 23. Mai 1996 Geliefert am 30. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fastline LTD (the "parent") or any beneficiary of the loan stock pursuant to a loan stock certificate issued by the parent to apax fund nominees limited d account and consisting of £2,000,000 secured loan stock 1999 - 2001 (the "loan stock certificate") and by the company under the composite guarantee and mortgage debenture granted by the company in favour of apax partners & co ventures limited ("apax") of even date with this deed | |
Kurze Angaben 1. sun alliance policy no: 9194867 dated 3 april 1996 in respect of david philip doggett for the sum assured of £1,000,000; and 2. sun alliance policy no: 9194870 dated 26 march 1996 in respect of david douglas for the sum assured of £500,000; and the proceeds payable in respect of such policies. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 23. Mai 1996 Geliefert am 30. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therin to the chargee pursuant to the loan stock certificate issued by the company to apax fund nominees limited d account and consisting of £2,000,000 secured loan stock 1999-2001 | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage, all estate and interest of such company in the following freehold and leasehold property: l/h-property situate and k/a engineers depot, nightingale road, horsham, west sussex, the property k/a the guide bridge, engineers yard, guide lane, guide bridge greater manchester, the property situate and k/a tuebrook sidings off weavertree boulevard weavertree liverpool. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of security | Erstellt am 23. Mai 1996 Geliefert am 30. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility agreement dated 23RD may 1996 | |
Kurze Angaben All rights title and interest by way of guarantee or otherwise in to or arising out of of the charged documents as defined in a composite guarantee and mortgage debenture dated 23/5/96 inc, all claims for damages or other remedies in respect of any breach of the agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 22. Mai 1996 Geliefert am 28. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All its right title & interest in and to a sun alliance pooicy dated 3/4/96 in the name of david philip doggett policy no 9194867 in an amount of £1,000,000 and a sun alliance policy. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 15. März 1996 Geliefert am 21. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee on any account whatsoever including for the avoidence of doubt but without limitation all liabilities pursuant to the facility agreement and/or any hedging agreement (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of security | Erstellt am 15. März 1996 Geliefert am 20. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement (as defined in the deed) | |
Kurze Angaben All the company's rights, title and interest arising out of the agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0