JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED

JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJARVIS FASTLINE GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03023442
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FASTLINE GROUP LTD19. März 199619. März 1996
    FASTLINE RAIL SERVICES LIMITED17. Feb. 199517. Feb. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. März 2010

    Kapitalaufstellung am 17. März 2010

    • Kapital: GBP 3,535,086
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    13 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2007

    4 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    24 Seiten395

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005

    16 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Sekretär
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    70053320013
    AKINLADE, Mark Adeyemi Asagba
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish116740230002
    LAIRD, Stuart Wilson
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish60742240002
    THORNTON, Richard Michael
    17 Collingwood Drive
    NE46 2JA Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    17 Collingwood Drive
    NE46 2JA Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish98817540001
    DOW, Andrew Richard George
    Sycamore House
    Station Lane
    YO6 1AG Shipton-By-Beningbrough
    Yorkshire
    Sekretär
    Sycamore House
    Station Lane
    YO6 1AG Shipton-By-Beningbrough
    Yorkshire
    British42333690002
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Sekretär
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British20374510001
    TEMPLES (NOMINEES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004500001
    ALDERSON, David
    40 Laburnum Grove
    Sunniside
    NE16 5LY Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    40 Laburnum Grove
    Sunniside
    NE16 5LY Newcastle Upon Tyne
    British46972350001
    ARMITAGE, Peter Robert
    Coach House
    Sycamore Lane Springwood Road
    HD7 2SJ Holmfirth
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Coach House
    Sycamore Lane Springwood Road
    HD7 2SJ Holmfirth
    West Yorkshire
    British107266580001
    BRAZIER, Martin
    14 Cleve Avenue
    Toton
    NG9 6JH Nottingham
    Geschäftsführer
    14 Cleve Avenue
    Toton
    NG9 6JH Nottingham
    EnglandBritish77374440002
    BROADBENT, Noel
    21 Kerver Lane
    Dunnington
    YO19 5SL York
    Geschäftsführer
    21 Kerver Lane
    Dunnington
    YO19 5SL York
    EnglandBritish60192070001
    CLARKE, Robert John
    Candacraig
    Wass
    YO61 4AX York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Candacraig
    Wass
    YO61 4AX York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish83691100001
    CUNNINGHAM, Anthony
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135811090001
    DAVIES, William Richard
    35 Jervis Court
    Sutton On Derwent
    YO41 4JX York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    35 Jervis Court
    Sutton On Derwent
    YO41 4JX York
    North Yorkshire
    British102300730001
    DOGGETT, David Philip
    2 Holly Bank Hodgson Lane
    Upper Poppleton
    YO2 6DZ York
    Geschäftsführer
    2 Holly Bank Hodgson Lane
    Upper Poppleton
    YO2 6DZ York
    British41122990001
    DOUGLAS, David
    The Croft
    Hodgson Lane, Upper Poppleton
    YO26 6EA York
    Geschäftsführer
    The Croft
    Hodgson Lane, Upper Poppleton
    YO26 6EA York
    EnglandBritish119255740001
    DOW, Andrew Richard George
    Sycamore House
    Station Lane
    YO6 1AG Shipton-By-Beningbrough
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Sycamore House
    Station Lane
    YO6 1AG Shipton-By-Beningbrough
    Yorkshire
    British42333690002
    DOYLE, Robert John
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    British79420210002
    GORDON, Ray
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    British102379260001
    HALL, Richard Gordon
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    Geschäftsführer
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    EnglandBritish771320001
    HOUGHTON, Michael David
    Field House Back Lane
    Retford Road
    S81 8HB Blyth
    Geschäftsführer
    Field House Back Lane
    Retford Road
    S81 8HB Blyth
    British98817600002
    HURRELL, Stephen Glynn
    49 Church Street
    Long Bennington
    NG23 5ES Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    49 Church Street
    Long Bennington
    NG23 5ES Newark
    Nottinghamshire
    British50751120001
    HURRELL, Stephen Glynn
    49 Church Street
    Long Bennington
    NG23 5ES Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    49 Church Street
    Long Bennington
    NG23 5ES Newark
    Nottinghamshire
    British50751120001
    HYDE, Kevin Oliver
    12 Mount Parade
    YO24 4AB York
    Geschäftsführer
    12 Mount Parade
    YO24 4AB York
    British66509100002
    IVES, Charles Edmund
    12 Church Close
    Wingerworth
    S42 6QA Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    12 Church Close
    Wingerworth
    S42 6QA Chesterfield
    Derbyshire
    British78691290001
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    KEEGAN, James
    11 Stonegate
    Eston
    TS6 9NP Middlesbrough
    Cleveland
    Geschäftsführer
    11 Stonegate
    Eston
    TS6 9NP Middlesbrough
    Cleveland
    United KingdomBritish33140110001
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20374510001
    LAFFERTY, Henry
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    Geschäftsführer
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    EnglandBritish146249130001
    LEE, John Philip
    49 Usher Lane
    Haxby
    YO32 3LA York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    49 Usher Lane
    Haxby
    YO32 3LA York
    Yorkshire
    British58410390001
    LEZALA, Andrew Peter
    11 Finch Crescent
    Mickleover
    DE3 0TT Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    11 Finch Crescent
    Mickleover
    DE3 0TT Derby
    Derbyshire
    British85889200001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish37404250003
    MCKEEVER, Michael Stuart
    The Coach House
    Plainville Lane, Wigginton
    YO32 2RG York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Coach House
    Plainville Lane, Wigginton
    YO32 2RG York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish79851890002
    MOAYEDI, Paris
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    The Old House Bridge Green
    Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish2646590001

    Hat JARVIS FASTLINE GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 27. Juli 2006
    Geliefert am 08. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 09. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation the whole sums due to the chargee under and in terms of the facility letter from the chargee to the company dated 18TH september 1996; provided that the monies and liabilities which the company hereby covenants to pay and discharge shall not include any monies and liabilities arising under a regulate consumer credit agreement falling within part v of the consumer credit act 1974, unless specifically agreed in writing between the company and the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Erstellt am 23. Mai 1996
    Geliefert am 05. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement and/or any hedging agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of key-man policy
    Erstellt am 23. Mai 1996
    Geliefert am 30. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fastline LTD (the "parent") or any beneficiary of the loan stock pursuant to a loan stock certificate issued by the parent to apax fund nominees limited d account and consisting of £2,000,000 secured loan stock 1999 - 2001 (the "loan stock certificate") and by the company under the composite guarantee and mortgage debenture granted by the company in favour of apax partners & co ventures limited ("apax") of even date with this deed
    Kurze Angaben
    1. sun alliance policy no: 9194867 dated 3 april 1996 in respect of david philip doggett for the sum assured of £1,000,000; and 2. sun alliance policy no: 9194870 dated 26 march 1996 in respect of david douglas for the sum assured of £500,000; and the proceeds payable in respect of such policies.
    Berechtigte Personen
    • Apax Partners & Co Ventures Limited(As Security Trustee and Agent)
    Transaktionen
    • 30. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Erstellt am 23. Mai 1996
    Geliefert am 30. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therin to the chargee pursuant to the loan stock certificate issued by the company to apax fund nominees limited d account and consisting of £2,000,000 secured loan stock 1999-2001
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage, all estate and interest of such company in the following freehold and leasehold property: l/h-property situate and k/a engineers depot, nightingale road, horsham, west sussex, the property k/a the guide bridge, engineers yard, guide lane, guide bridge greater manchester, the property situate and k/a tuebrook sidings off weavertree boulevard weavertree liverpool. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Apax Partners & Co Ventures Limited(As Security Trustee and Agent)
    Transaktionen
    • 30. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of security
    Erstellt am 23. Mai 1996
    Geliefert am 30. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility agreement dated 23RD may 1996
    Kurze Angaben
    All rights title and interest by way of guarantee or otherwise in to or arising out of of the charged documents as defined in a composite guarantee and mortgage debenture dated 23/5/96 inc, all claims for damages or other remedies in respect of any breach of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 22. Mai 1996
    Geliefert am 28. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All its right title & interest in and to a sun alliance pooicy dated 3/4/96 in the name of david philip doggett policy no 9194867 in an amount of £1,000,000 and a sun alliance policy. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 28. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Erstellt am 15. März 1996
    Geliefert am 21. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee on any account whatsoever including for the avoidence of doubt but without limitation all liabilities pursuant to the facility agreement and/or any hedging agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of security
    Erstellt am 15. März 1996
    Geliefert am 20. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement (as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    All the company's rights, title and interest arising out of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0