AVANT (BBH) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAVANT (BBH) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03026597
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AVANT (BBH) LIMITED?

    • Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen

    Wo befindet sich AVANT (BBH) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AVANT (BBH) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AVANT (BEN BAILEY HOMES) LIMITED26. Okt. 201526. Okt. 2015
    BEN BAILEY HOMES LIMITED22. Apr. 201022. Apr. 2010
    GLADEDALE (CENTRAL DIVISION) LIMITED13. März 200713. März 2007
    GLADEDALE (CENTRAL) LIMITED30. Jan. 200730. Jan. 2007
    NORTHCOUNTRY HOMES GROUP LIMITED28. Feb. 200028. Feb. 2000
    PELHAM CONSTRUCTION LIMITED30. Juni 199530. Juni 1995
    FOCUSCOLOUR LIMITED27. Feb. 199527. Feb. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVANT (BBH) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für AVANT (BBH) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Voluntary strike off DS01 04/07/2022
    RES13

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Giles Henry Sharp als Geschäftsführer am 03. Juni 2022

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Richard Paul Stenhouse als Direktor am 11. März 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Jeffrey Fairburn als Direktor am 14. März 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Rachel Josephine Cowper als Sekretär am 30. Nov. 2021

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Joanne Elizabeth Massey als Sekretär am 30. Nov. 2021

    1 SeitenTM02

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2022 bis 30. Juni 2022

    1 SeitenAA01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2021 bis 30. Apr. 2021

    1 SeitenAA01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2021 bis 30. Juni 2021

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2021

    11 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Colin Edward Lewis als Geschäftsführer am 30. Apr. 2021

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 25. März 2021

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 01. Mai 2020

    11 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 02. Juli 2020

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Jeremy Hirst als Geschäftsführer am 30. März 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 03. Mai 2019

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. März 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Glyn David Mabey als Geschäftsführer am 10. Aug. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 27. Apr. 2018

    11 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von AVANT (BBH) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COWPER, Rachel Josephine
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Sekretär
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    290295420001
    FAIRBURN, Jeffrey
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector46703920004
    STENHOUSE, Richard Paul
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector 149324180001
    AYTON, Brian Robert
    Farriers End
    Bunny Hall Drive Bunny
    NG11 6QT Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Farriers End
    Bunny Hall Drive Bunny
    NG11 6QT Nottingham
    Nottinghamshire
    British34063800002
    BROWN, Nigel William
    60 Fountain Street
    M2 2FE Manchester
    Greater Manchester
    Sekretär
    60 Fountain Street
    M2 2FE Manchester
    Greater Manchester
    BritishCompany Secretary42413360002
    DOWSON, Cherry Kay
    116 St Catherines Grove
    LN5 8NB Lincoln
    Lincolnshire
    Sekretär
    116 St Catherines Grove
    LN5 8NB Lincoln
    Lincolnshire
    British21076310001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Sekretär
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    HIRST, Stephen Jeremy
    157 Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    Sekretär
    157 Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    BritishCompany Director95787000001
    JACKSON, John David
    Westfield
    Camp Lane Henley In Arden
    B95 5QQ Solihull
    Warwickshire
    Sekretär
    Westfield
    Camp Lane Henley In Arden
    B95 5QQ Solihull
    Warwickshire
    British57559420001
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Sekretär
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808330001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    ARMITAGE, Peter Robert
    Coach House
    Sycamore Lane Springwood Road
    HD7 2SJ Holmfirth
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Coach House
    Sycamore Lane Springwood Road
    HD7 2SJ Holmfirth
    West Yorkshire
    BritishVenture Capitalist107266580001
    ASKER, Giles Allen Trevor
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector75879360004
    ASKER, Giles Allen Trevor
    9 Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    9 Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector75879360004
    AYTON, Brian Robert
    Farriers End
    Bunny Hall Drive Bunny
    NG11 6QT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Farriers End
    Bunny Hall Drive Bunny
    NG11 6QT Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector34063800002
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    EMMETT, Martin Damian
    60 Fountain Street
    M2 2FE Manchester
    Geschäftsführer
    60 Fountain Street
    M2 2FE Manchester
    BritishSolicitor43524180001
    EVANS, David Richard
    Ty Newydd Farm
    Ffordd Nercwys Treuddyn
    CH7 4BG Mold
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Ty Newydd Farm
    Ffordd Nercwys Treuddyn
    CH7 4BG Mold
    Clwyd
    BritishCompany Director20424380001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    FOSTER, David Martin
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director50285750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    HARRISON, Jolyon Leonard
    Woodbine Cottage Wigginton Road
    YO32 2RJ York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodbine Cottage Wigginton Road
    YO32 2RJ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector58843110002
    HIRST, Stephen Jeremy
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector95787000001
    HIRST, Stephen Jeremy
    157 Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    Geschäftsführer
    157 Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    United KingdomBritishGroup Finance Director95787000001
    JONES, Ian Martin Lloyd
    Hewland House Farm
    Rawden Hill Arthington
    LS21 1PS Leeds
    Geschäftsführer
    Hewland House Farm
    Rawden Hill Arthington
    LS21 1PS Leeds
    United KingdomBritishInvestment Director114746480001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    MABEY, Glyn David
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector100945610001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director148459300001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    Westerham
    TN16 1RG Kent
    30
    England And Wales
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    Westerham
    TN16 1RG Kent
    30
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishCfo207729000002
    MURRAY, Stephen
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director90170480001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AVANT (BBH) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer01043597
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat AVANT (BBH) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Apr. 2015
    Geliefert am 22. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 08. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 02. Apr. 2015
    Geliefert am 10. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 12. Feb. 2015
    Geliefert am 19. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent for the Beneficaries)
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 14. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A bond and floating charge
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Dez. 2008
    Geliefert am 09. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juni 2005
    Geliefert am 29. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a land on the south east side of chesterfield road barlborough t//n DY312019. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 15. Juni 2005
    Geliefert am 29. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 11. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a land on the south east side of chesterfield road, barlborough t/no DY312019. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 11. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Aug. 2000
    Geliefert am 23. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the south side of chesterfield road barlborough derbyshire t/no DY312019. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Nov. 1999
    Geliefert am 29. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at bottesford (west side of st davids crescent) north lincolnshire t/n HS165300. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Nov. 1999
    Geliefert am 26. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at terrace lane pleasley derbyshire. T/no. DY292177. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Okt. 1999
    Geliefert am 01. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a land at station road bolton on dearne south yorkshire t/n SYK63243. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Aug. 1999
    Geliefert am 02. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at station road bolsover chesterfield. T/nos. DY139094 and DY207132.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Juni 1999
    Geliefert am 12. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property k/a land at cooke street bentley doncaster south yorkshire t/n SYK3725638. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Juni 1999
    Geliefert am 14. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as land at wolsey way lincoln lincolnshire; part t/nos LL13044 and LL82233. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Okt. 1998
    Geliefert am 26. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at stinting lane shirebrook derbyshire t/n DY294257. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 1998
    Geliefert am 09. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at george street darfield barnsley south yorkshire.t/no.SYK380918.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Sept. 1998
    Geliefert am 30. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at bootham lane dunscroft doncaster south yorkshire t/no;-SYK127891. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Juli 1998
    Geliefert am 05. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at old hall farm pontfract west yorkshire part t/n-WYK610698.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Juli 1998
    Geliefert am 17. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at coddington newark nottinghamshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Juli 1998
    Geliefert am 17. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at coddington newark nottinghamshire t/n NT252395. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1998
    Geliefert am 14. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at newark road south hykeham lincolnshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 1998
    Geliefert am 03. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land lying on the west side of rectory road long duckmanton chesterfield derbyshire.t/nos.DY18049 (part) DY289002 and DY289004.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0