AVANT (BBH) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | AVANT (BBH) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03026597 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AVANT (BBH) LIMITED?
- Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen
Wo befindet sich AVANT (BBH) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AVANT (BBH) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AVANT (BEN BAILEY HOMES) LIMITED | 26. Okt. 2015 | 26. Okt. 2015 |
BEN BAILEY HOMES LIMITED | 22. Apr. 2010 | 22. Apr. 2010 |
GLADEDALE (CENTRAL DIVISION) LIMITED | 13. März 2007 | 13. März 2007 |
GLADEDALE (CENTRAL) LIMITED | 30. Jan. 2007 | 30. Jan. 2007 |
NORTHCOUNTRY HOMES GROUP LIMITED | 28. Feb. 2000 | 28. Feb. 2000 |
PELHAM CONSTRUCTION LIMITED | 30. Juni 1995 | 30. Juni 1995 |
FOCUSCOLOUR LIMITED | 27. Feb. 1995 | 27. Feb. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVANT (BBH) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AVANT (BBH) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Giles Henry Sharp als Geschäftsführer am 03. Juni 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Paul Stenhouse als Direktor am 11. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jeffrey Fairburn als Direktor am 14. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Rachel Josephine Cowper als Sekretär am 30. Nov. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Elizabeth Massey als Sekretär am 30. Nov. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2022 bis 30. Juni 2022 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2021 bis 30. Apr. 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2021 bis 30. Juni 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Colin Edward Lewis als Geschäftsführer am 30. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 25. März 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 01. Mai 2020 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 02. Juli 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Jeremy Hirst als Geschäftsführer am 30. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 03. Mai 2019 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. März 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Glyn David Mabey als Geschäftsführer am 10. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 27. Apr. 2018 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AVANT (BBH) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWPER, Rachel Josephine | Sekretär | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 290295420001 | |||||||
FAIRBURN, Jeffrey | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 46703920004 | ||||
STENHOUSE, Richard Paul | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | England | British | Director | 149324180001 | ||||
AYTON, Brian Robert | Sekretär | Farriers End Bunny Hall Drive Bunny NG11 6QT Nottingham Nottinghamshire | British | 34063800002 | ||||||
BROWN, Nigel William | Sekretär | 60 Fountain Street M2 2FE Manchester Greater Manchester | British | Company Secretary | 42413360002 | |||||
DOWSON, Cherry Kay | Sekretär | 116 St Catherines Grove LN5 8NB Lincoln Lincolnshire | British | 21076310001 | ||||||
GANDHI, Devendra | Sekretär | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | Director | 75350600002 | |||||
HIRST, Stephen Jeremy | Sekretär | 157 Folds Lane S8 0ET Sheffield | British | Company Director | 95787000001 | |||||
JACKSON, John David | Sekretär | Westfield Camp Lane Henley In Arden B95 5QQ Solihull Warwickshire | British | 57559420001 | ||||||
JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
MASSEY, Joanne Elizabeth | Sekretär | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147808330001 | |||||||
BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
ARMITAGE, Peter Robert | Geschäftsführer | Coach House Sycamore Lane Springwood Road HD7 2SJ Holmfirth West Yorkshire | British | Venture Capitalist | 107266580001 | |||||
ASKER, Giles Allen Trevor | Geschäftsführer | Nicholas Way Corringham DN21 5QE Gainsborough 9 Lincolnshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 75879360004 | ||||
ASKER, Giles Allen Trevor | Geschäftsführer | 9 Nicholas Way Corringham DN21 5QE Gainsborough Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 75879360004 | ||||
AYTON, Brian Robert | Geschäftsführer | Farriers End Bunny Hall Drive Bunny NG11 6QT Nottingham Nottinghamshire | British | Director | 34063800002 | |||||
CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Geschäftsführer | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | Director | 154997530001 | ||||
DIPRE, John Vivian | Geschäftsführer | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 9018280015 | ||||
DIPRE, Remo | Geschäftsführer | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Director | 35117250001 | ||||
EMMETT, Martin Damian | Geschäftsführer | 60 Fountain Street M2 2FE Manchester | British | Solicitor | 43524180001 | |||||
EVANS, David Richard | Geschäftsführer | Ty Newydd Farm Ffordd Nercwys Treuddyn CH7 4BG Mold Clwyd | British | Company Director | 20424380001 | |||||
FITZSIMMONS, Neil | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69006050003 | ||||
FOSTER, David Martin | Geschäftsführer | Bear Park 31 Nightingale Road WD3 7DA Rickmansworth Hertfordshire | England | British | Company Director | 50285750005 | ||||
GAFFNEY, David | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | Director | 84605410002 | ||||
GANDHI, Devendra | Geschäftsführer | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | Director | 75350600002 | ||||
HARRISON, Jolyon Leonard | Geschäftsführer | Woodbine Cottage Wigginton Road YO32 2RJ York North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 58843110002 | ||||
HIRST, Stephen Jeremy | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 95787000001 | ||||
HIRST, Stephen Jeremy | Geschäftsführer | 157 Folds Lane S8 0ET Sheffield | United Kingdom | British | Group Finance Director | 95787000001 | ||||
JONES, Ian Martin Lloyd | Geschäftsführer | Hewland House Farm Rawden Hill Arthington LS21 1PS Leeds | United Kingdom | British | Investment Director | 114746480001 | ||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Cro | 137285750001 | ||||
LEWIS, Colin Edward | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | British | Director | 59395180001 | ||||
MABEY, Glyn David | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | British | Director | 100945610001 | ||||
MALDE, Nishith | Geschäftsführer | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | England | British | Company Director | 148459300001 | ||||
MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | High Street Westerham TN16 1RG Kent 30 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | Cfo | 207729000002 | ||||
MURRAY, Stephen | Geschäftsführer | Went View Great North Road WF8 3JP Wentbridge West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 90170480001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AVANT (BBH) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant Homes (England) Limited | 06. Apr. 2016 | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat AVANT (BBH) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 02. Apr. 2015 Geliefert am 22. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 02. Apr. 2015 Geliefert am 10. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 12. Feb. 2015 Geliefert am 19. Feb. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 01. Sept. 2009 Geliefert am 14. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A bond and floating charge | Erstellt am 01. Sept. 2009 Geliefert am 14. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Dez. 2008 Geliefert am 09. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juni 2005 Geliefert am 29. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property k/a land on the south east side of chesterfield road barlborough t//n DY312019. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Juni 2005 Geliefert am 29. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 11. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a land on the south east side of chesterfield road, barlborough t/no DY312019. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 11. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Aug. 2000 Geliefert am 23. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on the south side of chesterfield road barlborough derbyshire t/no DY312019. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Nov. 1999 Geliefert am 29. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at bottesford (west side of st davids crescent) north lincolnshire t/n HS165300. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 18. Nov. 1999 Geliefert am 26. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land at terrace lane pleasley derbyshire. T/no. DY292177. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 22. Okt. 1999 Geliefert am 01. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a land at station road bolton on dearne south yorkshire t/n SYK63243. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Aug. 1999 Geliefert am 02. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land at station road bolsover chesterfield. T/nos. DY139094 and DY207132.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. Juni 1999 Geliefert am 12. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The freehold property k/a land at cooke street bentley doncaster south yorkshire t/n SYK3725638. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 04. Juni 1999 Geliefert am 14. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as land at wolsey way lincoln lincolnshire; part t/nos LL13044 and LL82233. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Okt. 1998 Geliefert am 26. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land at stinting lane shirebrook derbyshire t/n DY294257. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1998 Geliefert am 09. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land at george street darfield barnsley south yorkshire.t/no.SYK380918.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Sept. 1998 Geliefert am 30. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at bootham lane dunscroft doncaster south yorkshire t/no;-SYK127891. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Juli 1998 Geliefert am 05. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land at old hall farm pontfract west yorkshire part t/n-WYK610698.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 08. Juli 1998 Geliefert am 17. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at coddington newark nottinghamshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 08. Juli 1998 Geliefert am 17. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at coddington newark nottinghamshire t/n NT252395. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 14. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at newark road south hykeham lincolnshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Jan. 1998 Geliefert am 03. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land lying on the west side of rectory road long duckmanton chesterfield derbyshire.t/nos.DY18049 (part) DY289002 and DY289004.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0