ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03030000 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED?
- (8021) /
Wo befindet sich ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HYDREX DORMANT LIMITED | 18. Mai 2010 | 18. Mai 2010 |
M.T.R. TRAINING LIMITED | 07. März 1995 | 07. März 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed hydrex dormant LIMITED\certificate issued on 06/12/11 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 3 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Carl Mark D'ammassa am 07. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan James Jordan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 35 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed M.T.R. training LIMITED\certificate issued on 18/05/10 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Crago als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Carl Mark D'ammassa als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Simcox als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'AMMASSA, Carl Mark | Geschäftsführer | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | United Kingdom | British | Group Chief Executive | 147037660007 | ||||
JORDAN, Alan James | Geschäftsführer | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | England | Irish | Group Finance Director | 150320720001 | ||||
ADDIS, Jonathan Peter | Sekretär | Park Hill B13 8DS Birmingham 98 West Midlands United Kingdom | British | Accountant | 260439420001 | |||||
FARMER, Timothy Paul | Sekretär | 76 Woolram Wygate PE11 1PE Spalding Lincolnshire | British | Company Director | 42280140004 | |||||
WOOD, Andrew Simon | Sekretär | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | British | Finance Director | 33951380003 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BONNEY, Richard Trevor | Geschäftsführer | The Gables Shardlow Road DE72 2AN Aston On Trent Derbyshire | United Kingdom | British | Civil Servant | 85837580001 | ||||
BRUCE, Herbert Alfred | Geschäftsführer | Alderney House 164 Main Road Quadring PE11 4PT Spalding Lincolnshire | United Kingdom | British | Engineer | 42280130002 | ||||
BRUCE, Linda Annette | Geschäftsführer | 164 Main Road Quadring PE11 4PT Spalding Lincolnshire | United Kingdom | British | Training | 53786640001 | ||||
CRAGO, Andrew Morley | Geschäftsführer | 34 Jubilee Way St Georges BS22 7DS Weston Super Mare North Somerset | England | British | Company Director | 53786570002 | ||||
CURD, Melvyn Ernest | Geschäftsführer | Springfields 52 Springfield Road TN38 0TZ St Leonards On Sea East Sussex | British | Consultant Engineer | 42864710002 | |||||
FARMER, Timothy Paul | Geschäftsführer | 76 Woolram Wygate PE11 1PE Spalding Lincolnshire | British | Company Director | 42280140004 | |||||
LAURENCE, John Alexander | Geschäftsführer | 109 New Road Stoke Gifford BS34 8TF Bristol Avon | British | Safety & Marketing | 64487580001 | |||||
PAYNE, David John | Geschäftsführer | 32b Calmore Road Totton SO40 8GF Southampton Hampshire | British | Consultant Engineer | 42864780001 | |||||
PHILIPS, Robert Berry | Geschäftsführer | 91 Priorway Avenue Borrowash DE72 3HX Derby | British | Signal Engineer/Director | 68515320002 | |||||
SIMCOX, Andrew James | Geschäftsführer | Ashley Drive South Ashley Heath BH24 2JP Ringwood 53 Hampshire United Kingdom | England | British | Managing Director | 41023640002 | ||||
WELCH, Barry Reginald Arthur | Geschäftsführer | 225 New Road Stoke Gifford BS34 8TG Bristol South Gloucestershire | British | Sales & Marketing | 82177520001 | |||||
WOOD, Andrew Simon | Geschäftsführer | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | England | British | Finance Director | 33951380003 |
Hat ROWDEN REALISATIONS 5 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 24. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. März 2006 Geliefert am 23. März 2006 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. März 2005 Geliefert am 17. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. März 2004 Geliefert am 10. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 28. Dez. 2001 Geliefert am 03. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0