GLS 153 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GLS 153 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03032729 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GLS 153 LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich GLS 153 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Enterprise Cadogan Pier Cheyne Walk Chelsea SW35RQ London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLS 153 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GLS 153 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Steven Boultbee Brooks als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Charmaine Boultbee Brooks als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 13 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Lee Roberts als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 14 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2007 | 15 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006 | 14 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2005 | 15 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2004 | 16 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2003 | 15 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von GLS 153 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor | Sekretär | Welcheston Farm Broadmoor Common Woolhope HR1 4QU Hereford Herefordshire | British | 82993640001 | ||||||
| BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor | Geschäftsführer | Welcheston Farm Broadmoor Common Woolhope HR1 4QU Hereford Herefordshire | United Kingdom | British | 82993640001 | |||||
| ROBERTS, Lee | Geschäftsführer | Cheyne Walk Chelsea SW35RQ London Enterprise Cadogan Pier | England | British | 61138670002 | |||||
| KING, John William, Group Captain | Sekretär | 36 Valiant House Vicarage Crescent SW11 3LU London | British | 46043270001 | ||||||
| KING, John William, Group Captain | Sekretär | 36 Valiant House Vicarage Crescent SW11 3LU London | British | 46043270001 | ||||||
| BOULTBEE BROOKS, Charmaine Joan | Geschäftsführer | Welcheston Farm Broadmoor Common Woolhope HR1 4QU Hereford Herefordshire | United Kingdom | British | 81478130001 | |||||
| BOULTBEE BROOKS, Steven John | Geschäftsführer | Babushka Cadogan Pier Chelsea Embankment SW3 5RQ London | England | British | 67458340001 | |||||
| CONLON, Michael | Geschäftsführer | 384 City Road EC1 2QA London | United Kingdom | British | 109352660001 | |||||
| CONLON, Michael | Geschäftsführer | 384 City Road EC1 2QA London | United Kingdom | British | 109352660001 | |||||
| CUFF, Zoe | Geschäftsführer | 26b Lynn Road SW12 9LA London | British | 66804700002 | ||||||
| FALKNER, Justine | Geschäftsführer | 18 Shevon Way CM14 4PJ Brentwood Essex | British | 40502490001 | ||||||
| JEFFERY, Nigel John | Geschäftsführer | 6 Squires Court 80 Arthur Road Wimbledon SW19 7DJ London | United Kingdom | British | 65718910001 | |||||
| KING, John William, Group Captain | Geschäftsführer | 36 Valiant House Vicarage Crescent SW11 3LU London | British | 46043270001 |
Hat GLS 153 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment | Erstellt am 09. Feb. 2001 Geliefert am 24. Feb. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by boultbee construction limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of boultbee construction limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and the other lenders on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of crusader house 12A horton road west drayton midd'x - MX250826. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 09. Feb. 2001 Geliefert am 24. Feb. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 29 october 1997 and to a legal charge dated 19 march 1999 | |
Kurze Angaben F/Hold land known as crusader house 12A horton road west drayton,london borough of hillingdon - MX250826; together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery..all monies deposited with the trustee..all rights and licences thereto and benefit of all leases,tenancies,agreements for lease,covenants,etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 02. Nov. 2000 Geliefert am 14. Nov. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to any lender (as defined) or for in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lender whether present or future on any account whatsoever including interest legal and other charges and expenses | |
Kurze Angaben All rights title benefits and interests of the company to the rents (as defined) including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed between the company and the trustee and supplemental to a deed dated 19TH march 1999 between the company and the trustee | Erstellt am 02. Nov. 2000 Geliefert am 14. Nov. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to the trustee or any lender (as defined) or for in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lender whether present or future on any account whatsoever including interest legal and other charges and expenses | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage property k/a 25 kings road reading berkshire - BK94299 together with all buildings erections and fixtures and fixed plant equipment and machinery and by way of fixed charge the moneys from time to time deposited with the trustee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 19. März 1999 Geliefert am 01. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of the properties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 19. März 1999 Geliefert am 01. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H units 17 and 18 angel gate city road london NGL717397, l/h unit 24 angel gate city road london NGL717394, l/h 142 & 144 holland park and part of 5 norland place kensington NGL284221 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge and floating charge | Erstellt am 16. Mai 1996 Geliefert am 25. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,200,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben 1). all that f/h property on the west side of old heath road colchester t/no:- EX415206 2). all that f/h land situate at worcester road kidderminster hereford and worcester 3). f/h property k/a 17,18,20 and 21 pershore road stirchley birmingham and 19 and 22 pershore road t/no's :- WM315174 and WM328939 first floating charge all assets property undertaking present and future including goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge and floating charge | Erstellt am 20. Juli 1995 Geliefert am 08. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £490,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Units 6A and 6B elgar estate, 1 elgar road, reading berkshire t/no: BK228635. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0