GLS 153 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGLS 153 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03032729
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GLS 153 LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich GLS 153 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Enterprise Cadogan Pier Cheyne Walk
    Chelsea
    SW35RQ London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLS 153 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für GLS 153 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Steven Boultbee Brooks als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Charmaine Boultbee Brooks als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    13 SeitenAA

    Ernennung von Mr Lee Roberts als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    14 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2007

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006

    14 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2005

    15 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2004

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2003

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von GLS 153 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor
    Welcheston Farm
    Broadmoor Common Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    Sekretär
    Welcheston Farm
    Broadmoor Common Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    British82993640001
    BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor
    Welcheston Farm
    Broadmoor Common Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Welcheston Farm
    Broadmoor Common Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish82993640001
    ROBERTS, Lee
    Cheyne Walk
    Chelsea
    SW35RQ London
    Enterprise Cadogan Pier
    Geschäftsführer
    Cheyne Walk
    Chelsea
    SW35RQ London
    Enterprise Cadogan Pier
    EnglandBritish61138670002
    KING, John William, Group Captain
    36 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    Sekretär
    36 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    British46043270001
    KING, John William, Group Captain
    36 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    Sekretär
    36 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    British46043270001
    BOULTBEE BROOKS, Charmaine Joan
    Welcheston Farm Broadmoor Common
    Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Welcheston Farm Broadmoor Common
    Woolhope
    HR1 4QU Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish81478130001
    BOULTBEE BROOKS, Steven John
    Babushka Cadogan Pier
    Chelsea Embankment
    SW3 5RQ London
    Geschäftsführer
    Babushka Cadogan Pier
    Chelsea Embankment
    SW3 5RQ London
    EnglandBritish67458340001
    CONLON, Michael
    384 City Road
    EC1 2QA London
    Geschäftsführer
    384 City Road
    EC1 2QA London
    United KingdomBritish109352660001
    CONLON, Michael
    384 City Road
    EC1 2QA London
    Geschäftsführer
    384 City Road
    EC1 2QA London
    United KingdomBritish109352660001
    CUFF, Zoe
    26b Lynn Road
    SW12 9LA London
    Geschäftsführer
    26b Lynn Road
    SW12 9LA London
    British66804700002
    FALKNER, Justine
    18 Shevon Way
    CM14 4PJ Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    18 Shevon Way
    CM14 4PJ Brentwood
    Essex
    British40502490001
    JEFFERY, Nigel John
    6 Squires Court
    80 Arthur Road Wimbledon
    SW19 7DJ London
    Geschäftsführer
    6 Squires Court
    80 Arthur Road Wimbledon
    SW19 7DJ London
    United KingdomBritish65718910001
    KING, John William, Group Captain
    36 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    Geschäftsführer
    36 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    British46043270001

    Hat GLS 153 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment
    Erstellt am 09. Feb. 2001
    Geliefert am 24. Feb. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by boultbee construction limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of boultbee construction limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and the other lenders on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of crusader house 12A horton road west drayton midd'x - MX250826. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 09. Feb. 2001
    Geliefert am 24. Feb. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 29 october 1997 and to a legal charge dated 19 march 1999
    Kurze Angaben
    F/Hold land known as crusader house 12A horton road west drayton,london borough of hillingdon - MX250826; together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery..all monies deposited with the trustee..all rights and licences thereto and benefit of all leases,tenancies,agreements for lease,covenants,etc.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 02. Nov. 2000
    Geliefert am 14. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to any lender (as defined) or for in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lender whether present or future on any account whatsoever including interest legal and other charges and expenses
    Kurze Angaben
    All rights title benefits and interests of the company to the rents (as defined) including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited ("Trustee")
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed between the company and the trustee and supplemental to a deed dated 19TH march 1999 between the company and the trustee
    Erstellt am 02. Nov. 2000
    Geliefert am 14. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to the trustee or any lender (as defined) or for in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lender whether present or future on any account whatsoever including interest legal and other charges and expenses
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage property k/a 25 kings road reading berkshire - BK94299 together with all buildings erections and fixtures and fixed plant equipment and machinery and by way of fixed charge the moneys from time to time deposited with the trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited (Trustee)
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 19. März 1999
    Geliefert am 01. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of the properties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 19. März 1999
    Geliefert am 01. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H units 17 and 18 angel gate city road london NGL717397, l/h unit 24 angel gate city road london NGL717394, l/h 142 & 144 holland park and part of 5 norland place kensington NGL284221 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 16. Mai 1996
    Geliefert am 25. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,200,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    1). all that f/h property on the west side of old heath road colchester t/no:- EX415206 2). all that f/h land situate at worcester road kidderminster hereford and worcester 3). f/h property k/a 17,18,20 and 21 pershore road stirchley birmingham and 19 and 22 pershore road t/no's :- WM315174 and WM328939 first floating charge all assets property undertaking present and future including goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 20. Juli 1995
    Geliefert am 08. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £490,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Units 6A and 6B elgar estate, 1 elgar road, reading berkshire t/no: BK228635.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0