AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03032974 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 9th Floor 25 Farringdon Street EC4A 4AB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ENGINEHIGH LIMITED | 14. März 1995 | 14. März 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 16 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Corunna Court Corunna Road Warwick Warwickshire CV34 5HQ zum 9th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB am 07. Feb. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Juni 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Derek Thomas Batey am 01. Jan. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEY, Derek Thomas | Sekretär | 25 Farringdon Street EC4A 4AB London 9th Floor | British | 110838520001 | ||||||
| BUCKMASTER, Adrian Charles, Viscount | Geschäftsführer | The Close Holdfast Upton Upon Severn WR8 0QZ Worcester | United Kingdom | British | 56273950001 | |||||
| CARDINI, Filippo John | Sekretär | Flat 2 5/6 Bramham Gardens SW5 0JQ London | British | 56314170001 | ||||||
| GOODWIN, Lee David | Sekretär | Fox Corner 76 Foston Gate LE18 3SD Wigston Harcourt Leicestershire | British | 45740930001 | ||||||
| HALE, Clive Anthony | Sekretär | 27 Leamington Road CV3 6GF Coventry West Midlands | British | 30822970001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ARMSTRONG, Colin North | Geschäftsführer | Barton End Priors Barton SO23 9QF Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 172030620001 | |||||
| CARDINI, Filippo John | Geschäftsführer | Flat 2 5/6 Bramham Gardens SW5 0JQ London | British | 56314170001 | ||||||
| CONNOLLY, Kevin Brian | Geschäftsführer | The Old Tea Shop Church Street CV37 8EJ Welford On Avon Warwickshire | Irish | 54542950002 | ||||||
| GAUNT, Brian Martin | Geschäftsführer | Via Roma 1 22020 Torno (Como) Italy | Italy | British | 43138720001 | |||||
| HARGREAVES, David | Geschäftsführer | Willards Farm The Common Dunsfold GU8 4LB Godalming Surrey | British | 54809160001 | ||||||
| HARGREAVES, David | Geschäftsführer | Willards Farm The Common Dunsfold GU8 4LB Godalming Surrey | British | 54809160001 | ||||||
| WOOD, Roger Norman Alexander | Geschäftsführer | High Leybourne Hascombe GU8 4AD Godalming Surrey | England | British | 529640001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge on cash collateral deposit | Erstellt am 31. Juli 2003 Geliefert am 08. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the mezzanine finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all its right, title and interest in the cash collateral account, the deposit moneys, the debt represented by the deposit mmoneys and any account contemplated by the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 12. Jan. 2001 Geliefert am 29. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee and to the lenders (as defined) together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Kurze Angaben The shares and all related rights, including, all dividends payable in relation thereto.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 23. Juni 1999 Geliefert am 08. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee and to the lenders (as defined) together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Kurze Angaben The shares and all related rights including all dividends payable in relation thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge of shares | Erstellt am 23. Juni 1999 Geliefert am 08. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined)to the banks (as defined) or any of them each or any of the finance documents (as defined)in each case together with all costs charges and expenses incurred by any bank in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the senior finance documents or mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Kurze Angaben The original shares and the voting rights pertaining thereto and all dividends pertaining thereto for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 23. Juni 1999 Geliefert am 08. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined)to the chargee (as agent and trustee for itself and each of the secured parties) and to the secured parties (as defined) or any of them under the senior facility agreement mezzanine facility agreement and each or any of the other senior finance documents and mezzanine finance documents (as defined) in each case together with all costs charges and expenses incurred by any secured party in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the senior finance documents or mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Kurze Angaben The pledgor transfers hypothecates pledges sets over and delivers uhto the agent the shares of capital stock in ap america inc (1,000 shares of common stock par value $0.01) and ap america automotive products inc (100 shares of common stock par value $0.01 please see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Juni 1999 Geliefert am 08. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined)to the chargee (as agent and trustee for itself and each of the lenders) and to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents (as defined) in each case together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the senior finance documents or mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Kurze Angaben Please refer to form 395 for full details of charged assets. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement | Erstellt am 07. Aug. 1998 Geliefert am 17. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the chargee acting as agent and trustee for itself and the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben All shares in automotive products benelux B.V. issued up until 7TH august 1998 and currently held by the pledgor consisting of 120 shares each with a nominal value of NLG1,000 and all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 20. Juli 1995 Geliefert am 09. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the finance documents or any other document securing any such liabilities | |
Kurze Angaben Pursuant to the pledge agreement the company pledges the shares and the related rights in favour of the pledgee as security for the payment and discharge of the secured liabilities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 27. Apr. 1995 Geliefert am 16. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations of each obligor to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents or any other document securing such liabilities | |
Kurze Angaben All shares (as described on the reverse of the form 395) and all related rights accruing to the shares. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 27. Apr. 1995 Geliefert am 16. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the lenders (as defined) or any of them under the finance documents or any other document evidencing or securing the liabilities up to the amount of lire 73,398,000,000 | |
Kurze Angaben All of the company's interest in auromotive products (italia) S.R.1. being it's quota of a nominal value of lire 33,400,000,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge | Erstellt am 27. Apr. 1995 Geliefert am 16. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The repayment up to the amount of lire 73,398,000,000 of the loans granted to marveldress limited by morgan grenfell & co.limited | |
Kurze Angaben The company pledges to the pledgee its quota of nominal value of lire 33,400,000,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge on shares | Erstellt am 27. Apr. 1995 Geliefert am 16. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents | |
Kurze Angaben The original shares and the voting rights and dividends attched to the shares please refer to form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 1995 Geliefert am 27. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor as defined therein to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or the mezzanine finance documents or any other document as defined in this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0