AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED

AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03032974
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ENGINEHIGH LIMITED14. März 199514. März 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    16 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Corunna Court Corunna Road Warwick Warwickshire CV34 5HQ zum 9th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB am 07. Feb. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Jan. 2017

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. März 2016

    Kapitalaufstellung am 24. März 2016

    • Kapital: GBP 1,981,384
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 15. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 1,981,384
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. März 2014

    Kapitalaufstellung am 25. März 2014

    • Kapital: GBP 1,981,384
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    12 SeitenAA

    Kapitalaufstellung am 10. Juni 2013

    • Kapital: GBP 1,981,384
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Derek Thomas Batey am 01. Jan. 2010

    1 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BATEY, Derek Thomas
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    9th Floor
    Sekretär
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    9th Floor
    British110838520001
    BUCKMASTER, Adrian Charles, Viscount
    The Close Holdfast
    Upton Upon Severn
    WR8 0QZ Worcester
    Geschäftsführer
    The Close Holdfast
    Upton Upon Severn
    WR8 0QZ Worcester
    United KingdomBritish56273950001
    CARDINI, Filippo John
    Flat 2 5/6 Bramham Gardens
    SW5 0JQ London
    Sekretär
    Flat 2 5/6 Bramham Gardens
    SW5 0JQ London
    British56314170001
    GOODWIN, Lee David
    Fox Corner
    76 Foston Gate
    LE18 3SD Wigston Harcourt
    Leicestershire
    Sekretär
    Fox Corner
    76 Foston Gate
    LE18 3SD Wigston Harcourt
    Leicestershire
    British45740930001
    HALE, Clive Anthony
    27 Leamington Road
    CV3 6GF Coventry
    West Midlands
    Sekretär
    27 Leamington Road
    CV3 6GF Coventry
    West Midlands
    British30822970001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish172030620001
    CARDINI, Filippo John
    Flat 2 5/6 Bramham Gardens
    SW5 0JQ London
    Geschäftsführer
    Flat 2 5/6 Bramham Gardens
    SW5 0JQ London
    British56314170001
    CONNOLLY, Kevin Brian
    The Old Tea Shop
    Church Street
    CV37 8EJ Welford On Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Old Tea Shop
    Church Street
    CV37 8EJ Welford On Avon
    Warwickshire
    Irish54542950002
    GAUNT, Brian Martin
    Via Roma 1
    22020 Torno (Como)
    Italy
    Geschäftsführer
    Via Roma 1
    22020 Torno (Como)
    Italy
    ItalyBritish43138720001
    HARGREAVES, David
    Willards Farm The Common
    Dunsfold
    GU8 4LB Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Willards Farm The Common
    Dunsfold
    GU8 4LB Godalming
    Surrey
    British54809160001
    HARGREAVES, David
    Willards Farm The Common
    Dunsfold
    GU8 4LB Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Willards Farm The Common
    Dunsfold
    GU8 4LB Godalming
    Surrey
    British54809160001
    WOOD, Roger Norman Alexander
    High Leybourne
    Hascombe
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    High Leybourne
    Hascombe
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    EnglandBritish529640001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge on cash collateral deposit
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 08. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the mezzanine finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all its right, title and interest in the cash collateral account, the deposit moneys, the debt represented by the deposit mmoneys and any account contemplated by the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 12. Jan. 2001
    Geliefert am 29. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee and to the lenders (as defined) together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Kurze Angaben
    The shares and all related rights, including, all dividends payable in relation thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 23. Juni 1999
    Geliefert am 08. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee and to the lenders (as defined) together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Kurze Angaben
    The shares and all related rights including all dividends payable in relation thereto.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders
    Transaktionen
    • 08. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of pledge of shares
    Erstellt am 23. Juni 1999
    Geliefert am 08. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined)to the banks (as defined) or any of them each or any of the finance documents (as defined)in each case together with all costs charges and expenses incurred by any bank in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the senior finance documents or mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Kurze Angaben
    The original shares and the voting rights pertaining thereto and all dividends pertaining thereto for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 23. Juni 1999
    Geliefert am 08. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined)to the chargee (as agent and trustee for itself and each of the secured parties) and to the secured parties (as defined) or any of them under the senior facility agreement mezzanine facility agreement and each or any of the other senior finance documents and mezzanine finance documents (as defined) in each case together with all costs charges and expenses incurred by any secured party in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the senior finance documents or mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Kurze Angaben
    The pledgor transfers hypothecates pledges sets over and delivers uhto the agent the shares of capital stock in ap america inc (1,000 shares of common stock par value $0.01) and ap america automotive products inc (100 shares of common stock par value $0.01 please see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 1999
    Geliefert am 08. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined)to the chargee (as agent and trustee for itself and each of the lenders) and to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents (as defined) in each case together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the senior finance documents or mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Kurze Angaben
    Please refer to form 395 for full details of charged assets. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share pledge agreement
    Erstellt am 07. Aug. 1998
    Geliefert am 17. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the chargee acting as agent and trustee for itself and the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All shares in automotive products benelux B.V. issued up until 7TH august 1998 and currently held by the pledgor consisting of 120 shares each with a nominal value of NLG1,000 and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limited
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 20. Juli 1995
    Geliefert am 09. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the finance documents or any other document securing any such liabilities
    Kurze Angaben
    Pursuant to the pledge agreement the company pledges the shares and the related rights in favour of the pledgee as security for the payment and discharge of the secured liabilities.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co.Limitedas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders
    Transaktionen
    • 09. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 27. Apr. 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of each obligor to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents or any other document securing such liabilities
    Kurze Angaben
    All shares (as described on the reverse of the form 395) and all related rights accruing to the shares.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limited
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 27. Apr. 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (as defined) or any of them under the finance documents or any other document evidencing or securing the liabilities up to the amount of lire 73,398,000,000
    Kurze Angaben
    All of the company's interest in auromotive products (italia) S.R.1. being it's quota of a nominal value of lire 33,400,000,000.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co.Limitedas Agent and Trustee for Itself and the Lenders
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of pledge
    Erstellt am 27. Apr. 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The repayment up to the amount of lire 73,398,000,000 of the loans granted to marveldress limited by morgan grenfell & co.limited
    Kurze Angaben
    The company pledges to the pledgee its quota of nominal value of lire 33,400,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limited
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of pledge on shares
    Erstellt am 27. Apr. 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the obligors to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents
    Kurze Angaben
    The original shares and the voting rights and dividends attched to the shares please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limitedas Agent and Trsutee for Itself and the Lenders
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 1995
    Geliefert am 27. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor as defined therein to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or the mezzanine finance documents or any other document as defined in this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limited(The "Security Agent") as Agent and Trustee Foritself and Each of the Lenders (as Defined Therein)
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AUTOMOTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Jan. 2017Beginn der Liquidation
    09. Feb. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew Richard Meadley Wild
    9th Floor, 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    9th Floor, 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Mark John Wilson
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0