LGL 1996 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LGL 1996 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03034136 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LGL 1996 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LGL 1996 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lumns Lane M27 8LN Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LGL 1996 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LUXFER GROUP 1996 LIMITED | 03. Juli 2000 | 03. Juli 2000 |
| LUXFER GROUP LIMITED | 03. Okt. 1997 | 03. Okt. 1997 |
| BRITISH ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED | 04. Dez. 1995 | 04. Dez. 1995 |
| DMWSL 159 LIMITED | 16. März 1995 | 16. März 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LGL 1996 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LGL 1996 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 25 Seiten | MA | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Anchorage Gateway 5 Anchorage Quay Salford M50 3XE zum Lumns Lane Manchester M27 8LN am 19. März 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Feb. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Jamie Mark Savage als Sekretär am 01. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Nicholas Fletcher als Sekretär am 01. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für David Nicholas Fletcher am 15. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Brian Gordon Purves am 15. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von David Nicholas Fletcher als Sekretär am 04. März 2016 | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Linda Frances Seddon als Sekretär am 04. März 2016 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LGL 1996 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVAGE, Jamie Mark | Sekretär | Lumns Lane M27 8LN Manchester | 241848520001 | |||||||
| PURVES, Brian Gordon | Geschäftsführer | Lumns Lane M27 8LN Manchester | England | British | 47456240002 | |||||
| BURNS, Richard | Sekretär | Scalebor House Moor Lane LS29 7AF Burley In Wharfedale | British | 60673970003 | ||||||
| DEMBLOWSKI, Denis Anthony | Sekretär | 15 Chemin De La Rochette FOREIGN Geneva 1202 Switzerland | American | 82569240001 | ||||||
| FLETCHER, David Nicholas | Sekretär | 5 Anchorage Quay M50 3XE Salford Anchorage Gateway | 206178230001 | |||||||
| SEDDON, Linda Frances | Sekretär | Le Petit Bois 12 Park Drive Hale WA15 9DH Altrincham Cheshire | British | 14578300002 | ||||||
| SEDDON, Linda Frances | Sekretär | Le Petit Bois 12 Park Drive Hale WA15 9DH Altrincham Cheshire | British | 14578300002 | ||||||
| DM COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 15th Floor Moor House 119 London Wall EC2Y 5ET London | 67382580001 | |||||||
| BOYLE, Tobias Humphrey James | Geschäftsführer | 67 Carlton Hill NW8 0EN London | England | British | 141831310001 | |||||
| COMFORT, William Twyman | Geschäftsführer | Flat 1 38 Pont Street SW1 London | British | 53760460001 | ||||||
| DEMBLOWSKI, Denis Anthony | Geschäftsführer | 15 Chemin De La Rochette FOREIGN Geneva 1202 Switzerland | American | 82569240001 | ||||||
| FARGAS MAS, Lluis Maria | Geschäftsführer | Rue De Lausanne 62 Morges Vaud 1110 Switzerland | Switzerland | Spanish | 72852990001 | |||||
| FAULL, Ian Trevor | Geschäftsführer | West Chalet Groves Avenue Langland SA3 4QF Swansea West Glamorgan | United Kingdom | British | 12734690001 | |||||
| JACOB, Frances Carol | Geschäftsführer | 11 Augustus Court Augustus Road Southfields SW19 6NA London | British | 38154840001 | ||||||
| MACKENZIE, Alexander Donald | Geschäftsführer | Shalden Lodge Shalden Lane Shalden GU34 4DU Alton Hampshire | United Kingdom | British | 105120270001 | |||||
| MCKAY, Francis John | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | British | 78787530001 | ||||||
| MCKINNON, Ian Bannochie | Geschäftsführer | 219 Inner Promenade FY8 1EA Lytham St Annes Lancashire | England | British | 980160001 | |||||
| MCKINNON, Ian Bannochie | Geschäftsführer | 219 Inner Promenade FY8 1EA Lytham St Annes Lancashire | England | British | 980160001 | |||||
| MITCHELL, Raymond Barnes | Geschäftsführer | Av De Florimont 20 Bis 1006 FOREIGN Lausanne Switzerland | American | 72854970001 | ||||||
| MURRAY, Norman Loch | Geschäftsführer | 8 Pentland Avenue EH13 0HZ Edinburgh | Scotland | British | 22920002 | |||||
| MURRAY, Norman Loch | Geschäftsführer | 8 Pentland Avenue EH13 0HZ Edinburgh | Scotland | British | 22920002 | |||||
| PURVES, Brian Gordon | Geschäftsführer | 72a Macclesfield Road SK10 4BH Prestbury Cheshire | England | British | 47456240002 | |||||
| WHALLEY, Jeffrey | Geschäftsführer | Broncroft Castle Broncroft SY7 9HL Craven Arms Shropshire | United Kingdom | British | 1955430002 | |||||
| 25 NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Royal London House 22-25 Finsbury Square EC2A 1DX London | 42409900001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LGL 1996 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxfer Group Limited | 06. Apr. 2016 | 5, Anchorage Quay M50 3XE Salford Anchorage Gateway England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LGL 1996 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage of shares | Erstellt am 09. Apr. 1999 Geliefert am 28. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness and liabilities of any nature of each charging company (as defined) to the chargee (as security agent and trustee for itself and the other senior finance parties) and/or any of the senior finance parties (as defined) and/or any receiver under or in connection with the senior finance documents (as defined) including without limitation,under any amendments,supplements,or restatements of any of the senior finance documents including any containing provision for new or further advances) | |
Kurze Angaben Ordinary shares of 1 irish pound each in luxfer overseas holding limited and luxfer group limited all other securities rights and monies including without limitation dividends please refer to form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Apr. 1999 Geliefert am 27. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness and other liabilities of any nature of each charging company (as defined) to the chargee in it's capacity as security agent for itself and the other senior finance parties (as defined) and/or any of the senior finance parties and/or any receiver under or in connection with the senior finance documents (as defined) (including without limitation, under any amendments, supplements or restatements of any of the senior finance documents including any containing provision for new or further advances) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture subject to and with the benefit of the intercreditor agreement | Erstellt am 09. Feb. 1996 Geliefert am 14. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the chargee under the finance documents (or any of them) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0