PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03035572 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?
- (7020) /
Wo befindet sich PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Wigmore Street W1U 1PB London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PENN HOUSE (CHELTENHAM) LIMITED | 17. Nov. 1999 | 17. Nov. 1999 |
| WOODSFORD PROPERTIES (CHELTENHAM) LIMITED | 16. Jan. 1996 | 16. Jan. 1996 |
| WOODSFORD PROPERTIES (EDINBURGH) LIMITED | 21. März 1995 | 21. März 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 21. März 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870006 | ||||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | Floor 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd United Kingdom |
| 135316290001 | ||||||||||
| DENHAM, Timothy Maurice | Sekretär | Flat 12 31 Inverness Terrace W2 3JR London | British | 51492670001 | ||||||||||
| HOLLAND, Philip John | Sekretär | 9 Royle Close Chalfont St. Peter SL9 0BA Buckinghamshire | British | 74688330002 | ||||||||||
| LEWIS, Richard Reginald | Sekretär | 19 Woodsford Square W14 8DP London | British | 2942350001 | ||||||||||
| WHITE, Christine | Sekretär | 31 Denmark Street WD17 4YA Watford Hertfordshire | British | 74900200002 | ||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
| BONAVERO, Yves Jean Marc | Geschäftsführer | 54 St James`S Gardens W11 4RA London | England | French | 29119190003 | |||||||||
| CLEGG, Barry Stuart | Geschäftsführer | The Gate House 18a Ducks Hill Road HA6 2NR Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11296610002 | |||||||||
| DOSSETT, Roger John | Geschäftsführer | Charlecote Harewood Road HP8 4UA Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 116927100001 | |||||||||
| DUMAS, Markham Cresswell | Geschäftsführer | Curtis Farm Curtis Lane Headley GU35 8SA Bordon Hampshire | United Kingdom | British | 31098150001 | |||||||||
| HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | 61 Badgers Gate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | England | British | 163838050001 | |||||||||
| LEWIS, Richard Reginald | Geschäftsführer | 19 Woodsford Square W14 8DP London | United Kingdom | British | 2942350001 | |||||||||
| MALONE, Kenneth Daniel | Geschäftsführer | One Tree Cottage 18 Woodside Avenue HP9 1JJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 60687110001 | ||||||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 15. Sept. 2004 Geliefert am 29. Sept. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Sept. 2003 Geliefert am 11. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a unit 1 ravensbank business park ravensbank drive redditch t/n WR58721. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Sept. 2003 Geliefert am 11. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0