ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03036885 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED?
- (9305) /
Wo befindet sich ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bridge House, Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ANS CONTRACT HEALTHCARE (FALKIRK) LIMITED | 04. Apr. 1995 | 04. Apr. 1995 |
DAWNCLAY LIMITED | 23. März 1995 | 23. März 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas Tetley Beazley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Philip Reiter am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mahboob Ali Merchant am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Ellerby am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 15 Seiten | AA |
Wer sind die Geschäftsführer von ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||
BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | Director | 105797560001 | ||||
ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 40582650004 | ||||
GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | Director | 107664270001 | ||||
MERCHANT, Mahboob Ali | Geschäftsführer | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 56732410001 | ||||
REITER, Simon Philip | Geschäftsführer | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 England | United Kingdom | British | Finance Director | 135845570001 | ||||
KING, Robert Frederick | Sekretär | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||
COOPER, Richard Percy | Geschäftsführer | 39 Bathurst Mews W2 2SB London | British | Company Director | 14473540001 | |||||
DALY, Geoffrey William Stuart | Geschäftsführer | Sixpenny Buckle Coldhouse Hill GU22 0QS Woking Surrey | United Kingdom | British | Director | 19464860003 | ||||
DALY, Geoffrey William Stuart | Geschäftsführer | 97 Valiant House Vicarage Crescent SW11 3LX London | British | Company Director | 19464860001 | |||||
DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 29367700001 | ||||
DHANDSA, Narinder, Dr | Geschäftsführer | D102 Montevetro 100 Battersea Church Road Battersea SW11 3YL London | England | British | Company Director | 115844000001 | ||||
GRASSBY, Kevin Michael Peter | Geschäftsführer | 5 Campden Hill Court Campden Hill Road W8 7HX London | United Kingdom | British | Venture Capital Fund Manager | 66022700002 | ||||
KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 93897360003 | ||||
ROBINSON, Anthony Leake | Geschäftsführer | The Rose Garden Orchehill Avenue SL9 8QE Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Company Director | 48323880002 | |||||
SINCLAIR BROWN, Frederick John | Geschäftsführer | Rudge House Itchel Lane Crondall GU10 5PR Farnham Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 8070730003 | ||||
TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 62846800003 | ||||
WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 6658190001 | ||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Hat ANS CONTRACT HEALTHCARE (CAMBRIDGE) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2004 Geliefert am 14. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. März 2001 Geliefert am 11. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the facilities or the mezzanine loan facility | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Aug. 1998 Geliefert am 07. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The cambridge nursing home 5 chesterton high street cambridge cambridgeshire t/n cb 189356. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 09. Juli 1998 Geliefert am 16. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The cambridge nursing home 5 chesterton high street cambridge cambridgeshire t/no.CB189356. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 19. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of charge an agreement dated 10TH july 1997 relating to the cambridge nursing home 5 chester high street cambridge cambridgeshire t/n-CB189356.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 13. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The cambridge nursing home 5 chesterton high street cambridge cambridgeshire t/n CB189356. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 07. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. März 1996 Geliefert am 06. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of high street chesterton cambridge CB189356 together with all buildings and fixtures goodwill of any company relating to the property fixed charge over all plant machinery chattels and goods floating charge over all unattached property the rental sums together with the benefit of all rights thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. März 1996 Geliefert am 05. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade and tenants fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0