DILLONS UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDILLONS UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03040465
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DILLONS UK LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich DILLONS UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Windsor House
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DILLONS UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Apr. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DILLONS UK LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für DILLONS UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Ian Kenyon als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Trevor Moore als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Elaine Marriner als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Elaine Marriner als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Ian Peter Kenyon als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Trevor Philip Moore als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Simon Fox als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Apr. 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 02. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Shelley House 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR* am 13. März 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2011

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Apr. 2010

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Elaine Marriner am 21. Apr. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Richard Fox am 21. Apr. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Elaine Marriner am 21. Apr. 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Gerald Johnson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    13 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Apr. 2009

    3 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von DILLONS UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    British180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Sekretär
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Sekretär
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Sekretär
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British40470020001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Sekretär
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Sekretär
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Sekretär
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    British9950440002
    CALDWELL, Findlay Martin
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GbBritish50777030001
    FADIL, Susan Carol
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    British900006600001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    GUMMERS, Eric Michael
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    British900006590001
    HARRIS, Maxine
    Falcon House
    Hellidon Road
    CV47 7RN Priors Marston
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Falcon House
    Hellidon Road
    CV47 7RN Priors Marston
    Warwickshire
    British86121990001
    HOOD, John
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    British39644740001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Geschäftsführer
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    JOHNSON, Gerald Thomas
    Manor Farm House
    Oddington
    OX5 2RA Kidlington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Manor Farm House
    Oddington
    OX5 2RA Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish145115810001
    KENYON, Ian Peter
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107735600001
    LANDERS, Brian James
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish90246320001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish40470020001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British9406880001
    MCGLOIN, Brian Joseph Patrick
    72 Northumberland Road
    EN5 1EE Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    72 Northumberland Road
    EN5 1EE Barnet
    Hertfordshire
    British51112090001
    MCLAUGHLIN, Brian Finbar
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    United KingdomBritish9950470002
    MOORE, Trevor Philip
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113047410001
    ROGULSKA, Franca, Ms.
    Arcadia 5 Cornwall Close
    Warfield
    RG42 3UH Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Arcadia 5 Cornwall Close
    Warfield
    RG42 3UH Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish113630630002
    SINYOR, Joe
    5 Cotman Close
    NW11 6QD London
    Geschäftsführer
    5 Cotman Close
    NW11 6QD London
    British61172920002
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001
    WARNOCK, Shaw William
    3rd Floor
    58 Kensington Gardens Square
    W2 4BA London
    Geschäftsführer
    3rd Floor
    58 Kensington Gardens Square
    W2 4BA London
    EnglandBritish143882000001
    WOOD, Fiona Anne Murray
    27 Roehampton Lane
    SW15 5LS London
    Geschäftsführer
    27 Roehampton Lane
    SW15 5LS London
    EnglandBritish47935020001
    WORRALL, Brian George
    Apple House
    11a Sedgewell Road
    RG4 9TA Sonning Common
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Apple House
    11a Sedgewell Road
    RG4 9TA Sonning Common
    Berkshire
    United KingdomBritish107708510001

    Hat DILLONS UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 04. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amendment deed (to a debenture dated 28TH march 1998 as amended and restated on 14TH may 1998 the "amended and restated debenture")
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 03. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including all buildings fixtures book debts plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 03. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Erstellt am 14. Mai 1998
    Geliefert am 15. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 15. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation as "Security Agent"Which Expression Shall Include Any Person for the Time Being Appointed as Security Trustee or as an Additional Trustee for the Purpose of, and in Accordance with, the Senior Facility Agreement
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DILLONS UK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Juli 2013Antragsdatum
    02. Sept. 2013Beginn der Liquidation
    30. Apr. 2014Abschluss der Liquidation
    13. Aug. 2014Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or St Albans
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans
    Praktiker
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0