LAUNDRYCRAFT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LAUNDRYCRAFT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03043317 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LAUNDRYCRAFT LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LAUNDRYCRAFT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Intec 3 Wade Road RG24 8NE Basingstoke England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LAUNDRYCRAFT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COLCO 16 LIMITED | 07. Apr. 1995 | 07. Apr. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LAUNDRYCRAFT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LAUNDRYCRAFT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 19. Juli 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Franklin als Direktor am 03. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Dez. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lesley Anne Batty als Geschäftsführer am 13. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Berendsen Uk Limited as a person with significant control on 03. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Knightsbridge London SW1X 7LX England zum Intec 3 Wade Road Basingstoke RG24 8NE am 03. Apr. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Lesley Anne Batty als Direktor am 31. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Quinn als Geschäftsführer am 31. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Lawler als Sekretär am 08. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr David Andrew Lawler am 26. Apr. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Grosvenor Place London SW1X 7DL zum 1 Knightsbridge London SW1X 7LX am 26. Apr. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 1 Knightsbridge London SW1X 7LX verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark South als Direktor am 23. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LAUNDRYCRAFT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN, Mark Leslie | Geschäftsführer | Wade Road RG24 8NE Basingstoke Intec 3 Intec Business Park England England | England | British | 251161800001 | |||||
| SOUTH, Mark | Geschäftsführer | Wade Road RG24 8NE Basingstoke Intec 3 England | United Kingdom | British | 221291190001 | |||||
| BOWLER, Iain William | Sekretär | 148 Scarr Bottom Road Pye Nest HX2 7DZ Halifax West Yorkshire | British | 42701090002 | ||||||
| DAVIS, Carol Elizabeth | Sekretär | Rosebank The Street Tirley GL19 4ES Gloucester | British | 45796470001 | ||||||
| HIORNS, Nigel James | Sekretär | 62 Church Road CR0 1SB Croydon Surrey | British | 11524610002 | ||||||
| JONES, Paul Anthony | Sekretär | 11 Long Acre Rise Chineham RG24 8BD Basingstoke Hampshire | British | 47583780002 | ||||||
| LAWLER, David Andrew | Sekretär | Knightsbridge SW1X 7LX London 1 England | 221205630001 | |||||||
| BATTY, Lesley Anne | Gesch äftsführer | Wade Road RG24 8NE Basingstoke Intec 3 England | England | British | 196974110001 | |||||
| BOYLE, George Mathieson | Geschäftsführer | Strathern House Devonshire Avenue HP6 5JE Amersham Buckinghamshire | British | 102046460001 | ||||||
| CANTLEY, Stewart | Geschäftsführer | Broadlands Beggars Lane Longworth OX13 5BL Abingdon Oxfordshire | British | 73712080002 | ||||||
| DAVIS, Carol Elizabeth | Geschäftsführer | Rosebank The Street Tirley GL19 4ES Gloucester | British | 45796470001 | ||||||
| DYE, Iain Roger | Geschäftsführer | Russells Barn Rockwell End Hambleden RG9 6NG Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 44532410003 | |||||
| EMBLETON, Denis Michael | Geschäftsführer | 9 Leydene Park Hyden Farm Lane East Meon GU32 1HF Petersfield Hampshire | England | British | 12722390003 | |||||
| FINCH, Steven Richard | Geschäftsführer | 4 Grosvenor Place London SW1X 7DL | United Kingdom | British | 38003430003 | |||||
| IVEY, John Charles | Geschäftsführer | Tregenna 32 The Glen Farnborough Park BR6 8LR Orpington Kent | British | 8286080001 | ||||||
| JONES, Michael William | Geschäftsführer | 2 Zoar Street Morley LS27 8JD Leeds | British | 43689680002 | ||||||
| MARSLAND, David Fletcher | Geschäftsführer | 31 Leydene Park Hyden Farm Lane East Meon GU32 1HF Petersfield Hampshire | British | 54887690001 | ||||||
| PAINTER, Nicholas John | Geschäftsführer | 16 Oaklands Westwood Drive LS29 9RE Ilkley West Yorkshire | British | 39744480001 | ||||||
| QUINN, Kevin | Geschäftsführer | Knightsbridge SW1X 7LX London 1 England | England | British | 89902020003 | |||||
| WALKER, John Laurence | Geschäftsführer | The Spinney Firs Lane, Appleton WA4 5LD Warrington Cheshire | British | 85501290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LAUNDRYCRAFT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berendsen Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Wade Road RG24 8NE Basingstoke Intec 3 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LAUNDRYCRAFT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 05. Dez. 1995 Geliefert am 06. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 56 (or 52) southway walworth industrial estate andover hampshire SP10 5AE by way of fixed charge all buildings and other structures and goodwill all plant machinery and by way of assignment the rental sums by way of fixed charge the proceeds of any claim under any insurance policy. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Dez. 1995 Geliefert am 05. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises on the corner of wellington road north and lloyd road manchester t/n's LA56942 and LA56944 and by way of fixed charge all buildings and other structures any goodwill all plant machinery and other items and by way of assignment the rental sums. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 1995 Geliefert am 11. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/as land and buildings on the west side of milton street,mansfield,nottinghamshire together with all buildings and other structures,plant,machinery and other items fixed at any time thereon and goodwill or proceeds of any insurances relating thereto.floating charge over any additional property not effectively charged by way of fixed charge.by way of assignment,any rental sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 1995 Geliefert am 11. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/as 39 king street and 55 oakwood street,port talbot together with all buildings and other structures,plant,machinery and other items fixed at any time thereon and goodwill or proceeds of any insurances relating thereto.floating charge over any additional property not effectively charged by way of fixed charge.by way of assignment,any rental sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 1995 Geliefert am 11. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/as land and buildings on the north west side of buckwell end,wellinborough,northamptonshire together with all buildings and other structures,plant,machinery and other items fixed at any time thereon and goodwill or proceeds of any insurances relating thereto.floating charge over any additional property not effectively charged by way of fixed charge.by way of assignment,any ental sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 1995 Geliefert am 11. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/as land and buildings on the west side of sutton road,kidderminster and the dwellinghouse number 166 sutton road,kidderminster together with all buildings and other structures,plant,machinery and other items fixed at any time thereon and goodwill or proceeds of any insurances relating thereto.floating charge over additional property not effectively charged by way of fixed charge.by way of assignment any rental sums.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 1995 Geliefert am 11. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/as land and buildings on the north side of egerton road,whitchurch,north shropshire together with all buildings and other structures,plant,machinery and other items fixed at any time thereon and goodwill or proceeds of any insurances relating thereto.floating charge over the additional property not effectively charged by way of fixed charge.by way of assignment,any rental sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 1995 Geliefert am 11. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/as seal laundry,377 north circular road,london together with all buildings and other structures,plant,machinery and other items fixed at any time thereon and goodwill or proceeds of any insuances relating thereto.floating charge over any additional property not effectively charged by way of fixed charge.by way of assignment,any rental sums(as defined in the bank's commercial charge conditions). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juli 1995 Geliefert am 11. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0