PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03044788 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?
- Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21200) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Granary, The Courtyard Barns Choke Lane Cookham Dean SL6 6PT Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BUBBLECHARM LIMITED | 11. Apr. 1995 | 11. Apr. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Juni 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 26 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Shafiq Choudhary als Geschäftsführer am 30. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Shafiq Choudhary am 07. Aug. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Jorge Muntañola Prat als Direktor am 19. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rene Just als Geschäftsführer am 04. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Konstantin Von Alvensleben als Geschäftsführer am 03. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 25 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box SL6 6PT the Courtyard Barns the Courtyard Barns Choke Lane Maidenhead Berkshire SL6 6PT United Kingdom zum The Granary, the Courtyard Barns Choke Lane Cookham Dean Maidenhead Berkshire SL6 6PT am 15. Juli 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Rene Just als Direktor am 23. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Granary Courtyard Barns Choke Lane Maidenhead Berkshire SL6 6PT zum PO Box SL6 6PT the Courtyard Barns the Courtyard Barns Choke Lane Maidenhead Berkshire SL6 6PT am 24. Okt. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin James als Geschäftsführer am 16. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 25 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Uwe Salzer als Geschäftsführer am 31. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNTAÑOLA PRAT, Jorge | Geschäftsführer | Choke Lane Cookham Dean SL6 6PT Maidenhead The Granary, The Courtyard Barns Berkshire England | Spain | Spanish | 268494790001 | |||||
| BERESFORD, William Reginald | Sekretär | 17 Old Hall Court SY14 8NE Malpas Cheshire | British | 43357210001 | ||||||
| BOULTON, Paul | Sekretär | 365 Atherton Road Hindley WN2 3XD Wigan Lancashire | British | 38691820002 | ||||||
| NIGHTINGALE, John | Sekretär | 17 Waverton Mill Quays Waverton CH3 7PX Chester Cheshire | British | 43357120001 | ||||||
| BRIGHTON SECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex | 900004700001 | |||||||
| BERESFORD, William Reginald | Geschäftsführer | 17 Old Hall Court SY14 8NE Malpas Cheshire | United Kingdom | British | 43357210001 | |||||
| BOULTON, Paul | Geschäftsführer | Choke Lane SL6 6PT Maidenhead The Granary Courtyard Barns Berkshire | England | British | 38691820002 | |||||
| CHOUDHARY, Shafiq Mohammed, Dr | Geschäftsführer | Choke Lane Cookham Dean SL6 6PT Maidenhead The Granary, The Courtyard Barns Berkshire England | England | British | 109942870002 | |||||
| DICKSON, Brian, Dr | Geschäftsführer | Choke Lane SL6 6PT Maidenhead The Granary Courtyard Barns Berkshire | Usa | British | 7120320003 | |||||
| JAMES, Kevin | Geschäftsführer | Choke Lane SL6 6PT Maidenhead The Granary Courtyard Barns Berkshire | United Kingdom | British | 159118070001 | |||||
| JUST, Rene | Geschäftsführer | Choke Lane Cookham Dean SL6 6PT Maidenhead The Granary, The Courtyard Barns Berkshire England | Germany | Danish | 255117780001 | |||||
| NIGHTINGALE, John | Geschäftsführer | 17 Waverton Mill Quays Waverton CH3 7PX Chester Cheshire | British | 43357120001 | ||||||
| POOLE, Jeremy Frederick | Geschäftsführer | Crewe Hall Weston Road CW2 5XN Crewe Cheshire | England | British | 34237410003 | |||||
| SALZER, Uwe, Dr. | Geschäftsführer | Choke Lane SL6 6PT Maidenhead The Granary Courtyard Barns Berkshire | Germany | German | 213495730001 | |||||
| VIGGARS, Julian George | Geschäftsführer | 88 Whitbarrow Road WA13 9BA Lymm Cheshire | United Kingdom | British | 122088920001 | |||||
| VON ALVENSLEBEN, Konstantin | Geschäftsführer | Choke Lane Cookham Dean SL6 6PT Maidenhead The Granary, The Courtyard Barns Berkshire England | Germany | German | 202414100001 | |||||
| VON BUCHWALDT, Beatrix | Geschäftsführer | Choke Lane SL6 6PT Maidenhead The Granary Courtyard Barns Berkshire | Germany | German | 202414110001 | |||||
| WHITEMORE, Robert Leonard | Geschäftsführer | The Dovecote Main Street YO26 8JR Hessay Yorkshire | England | British | 98580600003 | |||||
| WRIGHT, Philip John | Geschäftsführer | Choke Lane SL6 6PT Maidenhead The Granary Courtyard Barns Berkshire | England | British | 200818410001 | |||||
| WYATT, Mark Andrew, Dr | Geschäftsführer | 14 Victoria Road FY8 1LE Lytham St Annes Lancashire | England | British | 248335090001 | |||||
| BRIGHTON DIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex | 900004690001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riemser Pharma Uk Limited | 07. Apr. 2016 | Courtyard Barns, Mount Farm Choke Lane SL6 6PT Maidenhead The Granary Berkshire England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 20. Nov. 2015 Geliefert am 23. Nov. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Aug. 2014 Geliefert am 13. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 15. Jan. 2014 Geliefert am 21. Jan. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 06. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2007 Geliefert am 08. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or its nominees | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property present and future including goodwill uncalled share capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2007 Geliefert am 08. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or its nominees | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property present and future including goodwill uncalled share capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Okt. 2000 Geliefert am 14. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Apr. 2000 Geliefert am 28. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the loan agreement of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Dez. 1999 Geliefert am 17. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 17. Okt. 1995 Geliefert am 23. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 08. Juni 1995 Geliefert am 20. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Kurze Angaben The interest in the interest earning account with the royal bank of scotland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0