HELLA UK HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HELLA UK HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03047679 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HELLA UK HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HELLA UK HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 6 E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Oxfordshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HELLA UK HOLDINGS LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HELLA UK HOLDINGS LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Jan. 2026 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 24. Jan. 2026 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Jan. 2025 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für HELLA UK HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Jan. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 265 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Jan. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2022 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Mai 2023 bis 31. Dez. 2022 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2021 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Mr Neil Grant as a person with significant control on 01. März 2021 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2020 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2019 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Spencer Mark Grinham als Direktor am 13. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Jan. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Neil Grant as a person with significant control on 01. Jan. 2020 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Cessation of Matthew Say as a person with significant control on 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Say als Geschäftsführer am 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Apr. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HELLA UK HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANT, Neil | Geschäftsführer | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire England | England | English | Finance Director | 201874350001 | ||||
GRINHAM, Spencer Mark | Geschäftsführer | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire | England | British | Soe Sales Director | 198154200001 | ||||
VOSS, Karsten | Geschäftsführer | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire | Germany | German | Head Of Corporate Accounting | 239937370001 | ||||
CHEESMAN, Andrew Ian | Sekretär | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire England | 167121130001 | |||||||
HARRISON, Irene Lesley | Bevollmächtigter Sekretär | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff South Glamorgan | British | 900003790001 | ||||||
HOLPIN, Peter Mario | Sekretär | Wildmere Industrial Estate Banbury OX16 3JU Oxon | British | Accountant | 95425930001 | |||||
SHANNON, Thomas John | Sekretär | East Lodge CV35 9BX Moreton Morrell Warwickshire | British | Accountant | 367210001 | |||||
BENZ, Wolfgang Peter | Geschäftsführer | Whittlebury House East Church Way Whittlebury NN12 8XF Towcester Northamptonshire | German | Company Director | 43129540003 | |||||
BROWN, Carl Edward | Geschäftsführer | Hawthorne House Common Hill Cricklade SN6 6EZ Swindon Wiltshire | British | Company Director | 94436320001 | |||||
CHEESMAN, Andrew Ian | Geschäftsführer | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire England | United Kingdom | British | Director | 167121080001 | ||||
HOLLAND, Christopher Roy | Geschäftsführer | Blue Cedar House Norton Grange, Little Kineton CV35 0DP Warwick Warwickshire | British | Engineer | 7673550002 | |||||
HOLPIN, Peter Mario | Geschäftsführer | Wildmere Industrial Estate Banbury OX16 3JU Oxon | England | British | Director | 95425930001 | ||||
POHLSCHIMIDT, Carl | Geschäftsführer | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire England | Germany | German | Group Accountant | 117165960001 | ||||
SAY, Matthew James Edward | Geschäftsführer | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire England | England | British | Managing Director | 199965210001 | ||||
SHANNON, Thomas John | Geschäftsführer | East Lodge CV35 9BX Moreton Morrell Warwickshire | British | Accountant | 367210001 | |||||
SUDKAMP, Hans | Geschäftsführer | C/O Rixbecker Stasse 75 4780 Lippstadt FOREIGN Germany | German | Finance Director | 42927300001 | |||||
BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Crown House 64 Whitchurch Road CF14 3LX Cardiff | 900005500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HELLA UK HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Neil Grant | 01. Jan. 2020 | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Matthew James Edward Say | 06. Apr. 2016 | E P S Industrial Estate, Appletree Road Chipping Warden OX17 1LL Banbury Unit 6 Oxfordshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0