CROWN DILMUN
Überblick
| Unternehmensname | CROWN DILMUN |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 03047853 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CROWN DILMUN?
- (7415) /
Wo befindet sich CROWN DILMUN?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROWN DILMUN?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2002 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CROWN DILMUN?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Andrew John Edwards als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 244 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 403b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 403b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CROWN DILMUN?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon | 900008790001 | |||||||
| EDWARDS, Andrew John | Geschäftsführer | Westhumble Street RH5 6BS Dorking 1 Burford Corner Surrey United Kingdom | England | English | 124890630001 | |||||
| FORD, Christopher Stewart Lacklan | Sekretär | 70 Pulteney Road E18 1PS London | British | 60840120001 | ||||||
| GRYKO, Witold Jan | Sekretär | 25 Beech Hall Crescent Highams Park E4 9NW London | United Kingdom | 20765220001 | ||||||
| MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED | Sekretär | Pickfords Wharf Clink Street SE1 9DG London | 32940220004 | |||||||
| AL ARADI, Sameer Salman | Geschäftsführer | House 1257 Road 7325 Area 373 Manama Bahrain | Bahraini | 70954350001 | ||||||
| BUCKLAND, John Milford | Geschäftsführer | 1 Hay Hill W1X 7LF London | British | 46831060003 | ||||||
| GAWTHORPE, Simon David | Geschäftsführer | Flat 9 61 & 69 Mortlake High Street SW14 8HL London | British | 141497020001 | ||||||
| GRYKO, Witold Jan | Geschäftsführer | 25 Beech Hall Crescent Highams Park E4 9NW London | United Kingdom | United Kingdom | 20765220001 | |||||
| KHOURI, William | Geschäftsführer | Little Greens 3 Hill Waye SL9 8BH Gerrards Cross Buckinghamshire | Usa | 62083250002 | ||||||
| MARLOWE, Walter Abraham | Geschäftsführer | 13 Redcliffe Road SW10 9NR London | American | 50107210001 | ||||||
| MCILVENNY, Robin Hugh | Geschäftsführer | 8 Cambridge Road HP9 1HW Beaconsfield Buckinghamshire | British | 17898090002 | ||||||
| MINASHI, Mark Anthony | Geschäftsführer | 21 Nightingale Road WD3 2DE Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 61124920002 | |||||
| SUTTON, Nicholas Nelson | Geschäftsführer | The Penthouse 25a Vincent House Vincent Square SW1P 2NB London | British | 38171430006 | ||||||
| TUPPEN, Jackie Mi Sin | Geschäftsführer | Pickfords Wharf SE1 9DG Clink Street London | British | 42837080001 | ||||||
| CROWN DILMUN(UK)HOLDINGS PLC | Geschäftsführer | 20-22 Bedford Row WC1R 4JS London | 81310260001 |
Hat CROWN DILMUN Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of deposit | Erstellt am 17. März 2006 Geliefert am 25. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £90,000 credited to account designation 96679611 with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 17. Aug. 2004 Geliefert am 27. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by crown dilmun (robertson street) limited and/ or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Twi issued ordinary shres of !.00 each of the company together with all rights and all dividends and other distributions. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 27. Juni 2003 Geliefert am 15. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (and/or to the hedging counterparty) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the investments including all rights of enforcement of the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 16. Juni 2003 Geliefert am 21. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rents, licence fees and premiums and other payments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 9TH may 2003 | Erstellt am 09. Mai 2003 Geliefert am 17. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £518,230 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 131 albion street glasgow and 60 -104 trongate glasgow t/no: GLA102505. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 12TH july 2002 | Erstellt am 28. Juni 2002 Geliefert am 19. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from crown dilmun albion street (C.I.) limited to the chargee and/or to the hedging counter party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 1-31 albion street glasgow and 60 to 104 trongate glasgow t/no: GLA102505. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit under seal -general (third party) charge | Erstellt am 22. Jan. 2001 Geliefert am 29. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from crown dilmun (westcliff village) limited (the "debtor") to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the issued share capital of the debtor (2 ordinary shares of £1), and/or proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 18TH december 2000 | Erstellt am 30. Nov. 2000 Geliefert am 02. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1-31 albion street and 60-104 trongate glasgow t/no: GLA102505. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 19. Mai 2000 Geliefert am 24. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 19. Mai 2000 Geliefert am 24. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 19. Nov. 1998 Geliefert am 08. Dez. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the national house building council for £160,000 | |
Kurze Angaben The sum of £160,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 96679611. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 30. Jan. 1998 Geliefert am 11. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of crown dilmun 5 LTD to the chargee on any account whatsoever and due from crown dilmun PLC under the share charge | |
Kurze Angaben (A) the investments;and (b) all dividends,interest and other money payable to itself in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable mortgage over securities | Erstellt am 06. Jan. 1998 Geliefert am 10. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or crown dilmun 4 limited to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the terms of the finance documents (as defined therein) or in connection with the loan facility or other financial accommodation from time to time granted pursuant thereto | |
Kurze Angaben All assets deriving from all shares in the borower to which the copany is beneficially entitled including all rights dividends interest income etc arising by way of conversion bonus exchange purchase or option etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 23. Apr. 1997 Geliefert am 01. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of the national house building council for £130,000 | |
Kurze Angaben The sum of £130,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 96679611. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 24. Apr. 1996 Geliefert am 30. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the national house building council for £100,000 | |
Kurze Angaben The sum of £100,000 now or to be held by the bank on an account numbered 96679611. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 15. Apr. 1996 Geliefert am 17. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of the national house building council for £100,000 | |
Kurze Angaben The sum of £100,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 96679611. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 09. Juni 1995 Geliefert am 20. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. Juni 1995 Geliefert am 20. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a bridgewater house 10-15 bridgewater square l/b of city of london t/no NGL243089 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0