PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03048528 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?
- (3410) /
Wo befindet sich PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 800 Field End Road South Ruislip HA4 0QH Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ASSETCO PAPWORTH LIMITED | 23. März 2004 | 23. März 2004 |
| ADVANCED TRANSPORT TECHNOLOGY LIMITED | 21. Apr. 1995 | 21. Apr. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2011 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2012 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Apr. 2017 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 05. Mai 2017 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 2 Seiten | F10.2 | ||||||||||
**Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 9 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
**Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 8 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Clissett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2011 bis 30. Sept. 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Mcdaid als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Continental Shelf 548 Limited als Direktor | 3 Seiten | AP02 | ||||||||||
Ernennung von Continental Shelf 547 Limited als Direktor | 3 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Brown als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Philip Mcdaid als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Brown als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Anthony Clissett als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marcus Shannon als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ricahrd Fulton als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Scott Brown als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Raymond Flynn als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Scott Douglas Brown als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ricahrd Fulton als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Lavender als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL SHELF 547 LIMITED | Geschäftsführer | Field End Road HA4 0QH South Ruislip 800 Middlesex England |
| 163247510001 | ||||||||||
| CONTINENTAL SHELF 548 LIMITED | Geschäftsführer | Field End Road HA4 0QH South Ruislip 800 Middlesex England |
| 163247580001 | ||||||||||
| BROWN, Scott | Sekretär | 800 Field End Road South Ruislip HA4 0QH Middlesex | Australian | 154943660001 | ||||||||||
| FAIERS, Colin Charles | Sekretär | 4 Elm Way Willingham CB4 5JS Cambridge Canbridgeshire | British | 157295550001 | ||||||||||
| FULTON, Ricahrd | Sekretär | Arthur Street BT1 4GA Belfast 21 Antrim | British | 154196160001 | ||||||||||
| HENWOOD, Julian Richard | Sekretär | 8 Brickyard Close CV7 7EN Balsall Common Warwickshire | British | 65188860002 | ||||||||||
| LAVENDER, Michael David | Sekretär | Forty Hill House EN2 9EU Forty Hill Middlesex | British | 149181030001 | ||||||||||
| LEWIN, Peter Jonathan | Sekretär | 2 Cormont Road SE5 9RA London | British | 45962560004 | ||||||||||
| MATTHEWS, Michael James | Sekretär | 11 Caxton Lane Foxton CB2 6SR Cambridge Cambridgeshire | British | 9389260001 | ||||||||||
| WATSON, Philip George | Sekretär | 29 Northcroft SG19 1JJ Sandy Bedfordshire | British | 42944690001 | ||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| SARCON COMPLIANCE LIMITED | Sekretär | Murray House Murray Street BT1 6DN Belfast Antrim | 143646650001 | |||||||||||
| BROWN, Scott Douglas | Geschäftsführer | 800 Field End Road South Ruislip HA4 0QH Middlesex | England | Australian | 183542790001 | |||||||||
| CLISSETT, Mark Anthony | Geschäftsführer | 800 Field End Road South Ruislip HA4 0QH Middlesex | United Kingdom | British | 159159010001 | |||||||||
| EDDY, Jonathan Charles Grenville | Geschäftsführer | Heath House Queen Mary Close GU51 4QR Fleet Hampshire | British | 72062400003 | ||||||||||
| FAIERS, Colin Charles | Geschäftsführer | 4 Elm Way Willingham CB4 5JS Cambridge Canbridgeshire | United Kingdom | British | 157295550001 | |||||||||
| FLYNN, Raymond Francis | Geschäftsführer | 66 Kiln Park BT39 0BB Templepatrick County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | 119131330001 | |||||||||
| HOUSDEN, Malcolm Brian | Geschäftsführer | 16 The Woodlands Broom SG18 9NH Biggleswade Bedfordshire | British | 31969440001 | ||||||||||
| LEWIN, Peter Jonathan | Geschäftsführer | 2 Cormont Road SE5 9RA London | United Kingdom | British | 45962560004 | |||||||||
| MCDAID, Philip | Geschäftsführer | Field End Road HA4 0QH South Ruislip 800 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | Irish | 161036530001 | |||||||||
| MELLON, Denis | Geschäftsführer | 19 Homewood Road AL1 4BG St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 105707560001 | |||||||||
| OLIVE, Michael Pelham Morris, Mr. | Geschäftsführer | Church Farm House Lower Basildon RG8 9NH Pangbourne Berkshire | England | British | 36404130004 | |||||||||
| REILLY, Paul | Geschäftsführer | Sonning Mead Thames Street RG4 6UR Sonning Berkshire | United Kingdom | British | 67639350002 | |||||||||
| SCOTT, George Douglas | Geschäftsführer | Hill Farm House Holywell PE27 4TG Huntingdon Cambridgeshire | British | 76708940001 | ||||||||||
| SHANNON, Marcus John | Geschäftsführer | 48 Loughanmore Road BT41 2HN Dunadry County Antrim N Ireland | United Kingdom | British | 108366960001 | |||||||||
| SMITH, David Michael | Geschäftsführer | 9 Crowdon Drive CV32 6NX Royal Leamington Spa Warwickshire | British | 119131400001 | ||||||||||
| WATSON, Philip George | Geschäftsführer | 29 Northcroft SG19 1JJ Sandy Bedfordshire | British | 42944690001 | ||||||||||
| WESTBURY, Peter | Geschäftsführer | Somerset Hill Holmbury St Mary RH5 6NR Dorking Surrey | United Kingdom | British | 2193910001 | |||||||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Hat PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Okt. 2008 Geliefert am 16. Okt. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 05. Okt. 2005 Geliefert am 12. Okt. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from sarcon vehicles limited to the chargee | |
Kurze Angaben The property k/a unit 1 papworth business park papworth everard cambridge & units 3/5 papworth business park papworth everard cambridge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 01. Nov. 2004 Geliefert am 03. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 5, papworth business park, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 01. Nov. 2004 Geliefert am 03. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 3, papworth business park, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 09. März 2000 Geliefert am 11. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property being unit 3,papworth business park,cambridge.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 11. Aug. 1999 Geliefert am 14. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juli 1999 Geliefert am 15. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Mai 1995 Geliefert am 13. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an acquisition agreement dated 10 may 1995 or this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Mai 1995 Geliefert am 06. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0