EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED

EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03049359
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED?

    • Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen (87200) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Voyage Care Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COMMUNITAS LIMITED25. Apr. 199525. Apr. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 030493590016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020

    28 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Shaun Parker als Direktor am 10. Jan. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Laura Cheryl Jordan als Sekretär am 10. Jan. 2019

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Philip Andre Sealey als Geschäftsführer am 10. Jan. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Philip Andre Sealey als Sekretär am 10. Jan. 2019

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    23 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Winning als Geschäftsführer am 09. Nov. 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    23 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 030493590016, erstellt am 08. Mai 2017

    87 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    40 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Purchase agreement 12/04/2017
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    22 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew John Cannon am 09. Juni 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 25. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    19 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JORDAN, Laura Cheryl
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Sekretär
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    254223630001
    CANNON, Andrew John
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director200461360002
    PARKER, Shaun
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director100048680001
    ALFLATT, John Neal
    The Old Rectory
    St Andrew Street
    SG14 1HZ Hertford
    Sekretär
    The Old Rectory
    St Andrew Street
    SG14 1HZ Hertford
    BritishDirector86320800002
    COLE, John Neil
    Lowander Church Lane
    Shadoxhurst
    TN26 1LY Ashford
    Kent
    Sekretär
    Lowander Church Lane
    Shadoxhurst
    TN26 1LY Ashford
    Kent
    BritishDirector69500640001
    FULLER, Jacqueline
    Woodend Cottage
    Ham Street
    TN26 2EB Ashford
    Kent
    Sekretär
    Woodend Cottage
    Ham Street
    TN26 2EB Ashford
    Kent
    British49556560001
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Sekretär
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    BritishFinance Director61663230001
    NAGI, Rabiya Sultana
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Sekretär
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    BritishSolicitor29667260001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Sekretär
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    176563720001
    THOMPSON, David Frederick
    33 Russell Road
    HA6 2LP Northwood
    Middlesex
    Sekretär
    33 Russell Road
    HA6 2LP Northwood
    Middlesex
    BritishDirector18580300001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BURCHETT, Rainer Harold
    Watermillock House
    Watermillock
    CA11 0JH Penrith
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Watermillock House
    Watermillock
    CA11 0JH Penrith
    Cumbria
    United KingdomBritishRetired80433200001
    BURNS, Thomas
    27 Park Avenue North
    NN3 2HT Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    27 Park Avenue North
    NN3 2HT Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Director78519600001
    COLE, John Neil
    Lowander Church Lane
    Shadoxhurst
    TN26 1LY Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Lowander Church Lane
    Shadoxhurst
    TN26 1LY Ashford
    Kent
    BritishDirector69500640001
    DONALDSON, Neil
    Ilg - St Georges House, Knoll
    Road, Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Geschäftsführer
    Ilg - St Georges House, Knoll
    Road, Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritishAccountant172494110001
    EDEN, Keith Leslie
    6 Friends Walk
    CB11 4EA Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    6 Friends Walk
    CB11 4EA Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishDirector53429470001
    FULLER, James Herbert
    Woodend Cottage
    Orlestone Hamstreet
    TN26 2EB Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Woodend Cottage
    Orlestone Hamstreet
    TN26 2EB Ashford
    Kent
    BritishDirector3999550001
    FULLER, James Herbert
    Woodend Cottage
    Orlestone Hamstreet
    TN26 2EB Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Woodend Cottage
    Orlestone Hamstreet
    TN26 2EB Ashford
    Kent
    BritishDirector3999550001
    HAYWARD, James Duncan Henry
    Ilg - St Georges House, Knoll
    Road, Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Geschäftsführer
    Ilg - St Georges House, Knoll
    Road, Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritishAccountant24500050002
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director61663230001
    LANE, Geoffrey Roy
    Larkrise
    Redcroft Walk
    GU6 8DS Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    Larkrise
    Redcroft Walk
    GU6 8DS Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director20198450001
    MCKENDRICK, James Bruce
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director154043480001
    PATEL, Mahesh Shivabhai
    29 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    29 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector80756410001
    ROBERTS, Kevin Wei
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishCompany Director72030660002
    SAVAGE, Andrew
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    Geschäftsführer
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    EnglandBritishManaging Director117869550001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Secretary45325360001
    THOMPSON, David Frederick
    33 Russell Road
    HA6 2LP Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    33 Russell Road
    HA6 2LP Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector18580300001
    TURNER, Thelma Lucille
    5 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    Cobblers Cottage
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    Cobblers Cottage
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector170427170001
    WHITTAKER, George Anthony David
    Ketton House
    Ketton
    PE9 3TD Aldgate
    Rutland
    Geschäftsführer
    Ketton House
    Ketton
    PE9 3TD Aldgate
    Rutland
    EnglandBritishDirector125108980001
    WINNING, Andrew
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishCompany Director73772160002
    HUTTON HOLDING LTD
    Croisette Casa Postale 730 Ch - 1214
    FOREIGN Vernier - Geneva
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Croisette Casa Postale 730 Ch - 1214
    FOREIGN Vernier - Geneva
    Switzerland
    100235920001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Voyage Care Limited
    Wall Island, Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    England
    06. Apr. 2016
    Wall Island, Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies
    Registrierungsnummer4250960
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat EVESLEIGH (EAST SUSSEX) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. Mai 2017
    Geliefert am 10. Mai 2017
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Mai 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 05. Mai 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed
    Erstellt am 03. Mai 2007
    Geliefert am 05. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a 46 st helens down hastings east sussex t/no HT15155 and all buildings and fixtures (including trade fixtures) thereon and plant and machinery from time to time thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland "Security Trustee"
    Transaktionen
    • 05. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Dez. 2006
    Geliefert am 29. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or other obligor to the security trustee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Wild acres (formerly seaton house) steeds lane kingsworth ashford kent t/n K645371, 106 queens road littlestone new romsey t/n K364221 & K382513, edmund house 66 st saviours road st leonards on sea east sussex, for details of further properties charged, please refer to form 395,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juli 2005
    Geliefert am 18. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Seaton house steed lane kingsnorth ashford kent t/n K645371, 106 queens road littlestone new romney kent t/n K364221 and K382513, 66 st saviours road hastings (also k/a edmund house) t/n NT16947. For further details please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juli 2005
    Geliefert am 18. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Seaton house steed lane kingsmorth ashford kent t/n K645371, 106 queens road littlestone new romney kent t/n's K364221 and K382513, 66 st saviours road hastings (also k/a edmund house) t/n HT16947. For further details please refer to form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Juli 2005
    Geliefert am 11. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All properties now owned by such company or in which such company has an interest,all present and future properties,all equipment,all securities,all debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Equity Partnership Investment Company PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 27. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a sturry villa 2 sturry hill sturry canterbury CT2 0NQ t/n K372154. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Second legal charge
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 11. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a penang charles road st leonards on sea east sussex; f/h property k/a 66 st saviours road, st leonards on sea east sussex; f/h property k/a 43 lower park road hastings east sussex t/nos: HT16947 HT3165 ESX22659. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Thomas Nee-Armagh Tagoe and Mrs Rosina Tagoe
    Transaktionen
    • 11. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all the freehold property known as 33 tower road west, st-leonards-on-sea, east sussex. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all the freehold property known as penang charles road, st-leonards-on-sea, east sussex. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all the freehold property known as 43 lower park road, hastings, east sussex. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all the freehold property known as 66 st saviours road, hastings, east sussex. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 09. März 1999
    Geliefert am 10. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the filberts straight lane brookland shepway kent t/no;-K183003. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 1998
    Geliefert am 05. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    106 queens road, littlestone on sea, new romsey, kent by way of fixed charge all buildings and other structures; goodwill of any business, plant, machinery and other items; an assignment of rental sums together with the benefit of all rights and remedies; proceeds of any claim of insurance. Floating charge over all unattached plant, machinery, chattels and goods.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 1997
    Geliefert am 29. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Seaton house, steeds lane, kingsworth, ashford, kent by way of fixed charge all buildings and other structures; goodwill of any business, plant, machinery and other items; an assignment of rental sums together with the benefit of all rights and remedies; proceeds of any claim of insurance. Floating charge over all unattached plant, machinery, chattels and goods.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 18. Aug. 1997
    Geliefert am 29. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Seaton house, steeds lane, kingsnorth, ashford, kent.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0