TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTITAN OUTDOOR GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03050296
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE MAIDEN GROUP PLC18. Juli 199518. Juli 1995
    NOONCROFT LIMITED26. Apr. 199526. Apr. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Apr. 2012

    12 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ am 26. Mai 2011

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Apr. 2011

    5 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    7 SeitenF10.2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 186 City Road London EC1V 2NT am 28. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 15. Apr. 2010

    LRESEX

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    16 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    15 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Sekretär
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    British122298900001
    ALLMAN, Donald Russell
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Geschäftsführer
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Usa113088010001
    APFELBAUM, William Michael
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Geschäftsführer
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    American113086280001
    GOLDSMITH, Scott
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Geschäftsführer
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    American111559610001
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Geschäftsführer
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish122298900001
    MOUG, Andrew John
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    EnglandBritish85481770002
    SLATKIN, Jonathan Aaron
    Flat 36 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    Geschäftsführer
    Flat 36 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    Usa117628600001
    SAVAGE, Timothy John
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    British8871460006
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BOASE, Martin
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    Geschäftsführer
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    United KingdomBritish1460150003
    BOYLE, Tobias Humphrey James
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    Geschäftsführer
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    EnglandBritish141831310001
    CARSLAW, Iain Alexander
    4 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    Geschäftsführer
    4 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    British31798100001
    DRON, David John Anthony
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    British1730460002
    GOODWIN, Francis Dominic
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    United KingdomUnited Kingdom127055040001
    POWELL, Ian
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    EnglandBritish33706140001
    PUGH, David John
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    Geschäftsführer
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    British70814670001
    REAY, Alison
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    EnglandBritish113085780001
    SWAINSON, John Frederick
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    British114617510001
    ZEGHIBE, Ronald William
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    Geschäftsführer
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    United KingdomAmerican51349440001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental rent deposit deed
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 01. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rent deposit standing to the credit of the designated account, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The New River Company Limited
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental rent deposit deed
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 01. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rent deposit standing to the credit of the designated account, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The New River Company Limited
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 18. Sept. 2007
    Geliefert am 25. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rent deposit deed from time to time standing to the credit of the designated account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Derwent Valley London Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 18. Sept. 2007
    Geliefert am 25. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rent deposit deed from time to time standing to the credit of the designated account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Derwent Valley London Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 18. Sept. 2007
    Geliefert am 25. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rent deposit deed from time to time standing to the credit of the designated account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Derwent Valley London Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 15. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from titan outdoor ireland limited and titan outdoor advertising limited to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights in and to the original shares any further shares and any related assets including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 15. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from titan outdoor ireland limited and titan outdoor advertising limited to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights in and to the original shares any further shares and any related assets including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 07. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, intellectual property and miscellaneous. Floating charge all its assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 12. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security deed
    Erstellt am 19. Juli 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the transaction parties (the security trustee) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All shares in the irish chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 19. Juli 2002
    Geliefert am 05. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 14. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Initial deposit of £2,000,000 credited to account no 550-0-08654557 with the bank and any addition thereon in any currency.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juni 1995
    Geliefert am 29. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 14 half moon street london (ngl 459043), l/h property k/a fifth floor churchill house titheborn street liverpool (MS108453), l/h property k/a suite 15 floor c josephs well westgate leeds. L/h property k/a part first floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a part second floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a unit 2 22/24 granville street birmingham.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co.Limitedthe "Security Agent"
    Transaktionen
    • 29. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TITAN OUTDOOR GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Aug. 2012Aufgelöst am
    15. Apr. 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0