ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED

ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03050677
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    • Produktion von Fernsehprogrammen (59113) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GLOBAL RADIO EAST MIDLANDS LIMITED15. Aug. 200715. Aug. 2007
    CHRYSALIS RADIO EAST MIDLANDS LIMITED23. Mai 200523. Mai 2005
    CENTURY RADIO 106 LIMITED21. Apr. 199821. Apr. 1998
    RADIO 106 FM LIMITED03. Sept. 199703. Sept. 1997
    EAST MIDLANDS BROADCASTING COMPANY LIMITED04. Juli 199504. Juli 1995
    LATLEES LIMITED27. Apr. 199527. Apr. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    13 SeitenAA

    legacy

    38 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2019

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2018

    • Kapital: GBP 1,000.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Keenan am 25. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Sekretär
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United KingdomBritishManaging Director109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishPublisher243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishFinance Director119137220004
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Sekretär
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    BritishCompany Director4459070001
    CUSICK, Nicholas Jonathan Paul
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    Sekretär
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    BritishComapny Secretary50942120001
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector54693600002
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Sekretär
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    BritishAccountant92875290001
    FLUET, Cliff
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    Sekretär
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    British97684290001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    Sekretär
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    British39878290001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Sekretär
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director116537370001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    SCHWARZ, Nathalie Esther
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    Sekretär
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    BritishCompany Secretary59245010001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BAXTER, Travis
    Le Morpeth Terrace
    SW1P 1EW London
    Geschäftsführer
    Le Morpeth Terrace
    SW1P 1EW London
    BritishCompany Director26244380001
    BEESLEY, Thomas Andrew
    Field House
    Owthorpe Lane
    NG12 3EH Kinoulton
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Field House
    Owthorpe Lane
    NG12 3EH Kinoulton
    Nottinghamshire
    EnglandBritishConsultant41597780001
    BOWLER, Timothy Richard
    39a Burlington Road
    Sherwood
    NG5 2GR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    39a Burlington Road
    Sherwood
    NG5 2GR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishPaper Merchant14072490001
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    BritishCompany Director4459070001
    BUCCI, Joanne
    Lodge House
    Lodge Lane
    NG13 8JN Screveton
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Lodge House
    Lodge Lane
    NG13 8JN Screveton
    Nottinghamshire
    EnglandBritishManaging Director83777300001
    CANTLE, Edward Francis
    Parkside
    Wollaton
    NG8 2NP Nottingham
    112
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Parkside
    Wollaton
    NG8 2NP Nottingham
    112
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishChief Executive124162790002
    COLES, Ronald John
    Manor Farm Main Street
    Upton
    NG23 5ST Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Manor Farm Main Street
    Upton
    NG23 5ST Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director9159370001
    CONNOLE, Michael Damien
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    Geschäftsführer
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    EnglandIrishAccountant47934750001
    DAVIDSON, Nicholas
    97 Pen Y Dre
    Rhiwbina
    CF14 6EL Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    97 Pen Y Dre
    Rhiwbina
    CF14 6EL Cardiff
    South Glamorgan
    BritishDirector71050910001
    DAVIES, Paul Richard
    28 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    Geschäftsführer
    28 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    BritishCompany Director55332120002
    DOBSON, Maureen
    The Cottage
    Cottage Lane South Collingham
    NG23 7LJ Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Cottage
    Cottage Lane South Collingham
    NG23 7LJ Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director27695370001
    EVANS, Mark Roy
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishFinance Director54693600002
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director54693600002
    FAIR, Julie
    716 Kenilworth Road
    Balsall Common
    CV7 7HD Coventry
    West Midlands
    Geschäftsführer
    716 Kenilworth Road
    Balsall Common
    CV7 7HD Coventry
    West Midlands
    EnglandBritishSales Director99687470001
    FAIRBURN, Paul Martin
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishBroadcasting Manager43039880003
    FIELDING, Samantha
    6 Periwood Grove
    Millhouses
    S8 0HX Sheffield
    Geschäftsführer
    6 Periwood Grove
    Millhouses
    S8 0HX Sheffield
    BritishHead Of Sales78849480001
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Geschäftsführer
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    United KingdomBritishAccountant92875290001
    HARRIS, Peter Jonathan
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    Geschäftsführer
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    EnglandBritishFinance Director40917640001
    HIGGINS, Lisa
    86 Thornfield Road
    Linthorpe
    TS5 5BY Middlesbrough
    Cleveland
    Geschäftsführer
    86 Thornfield Road
    Linthorpe
    TS5 5BY Middlesbrough
    Cleveland
    BritishBrand Marketing Director87568370001
    HURSTHOUSE, Roger Stephen
    3 Elm Park
    Gonalston Lane Epperstone
    NG14 6BE Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    3 Elm Park
    Gonalston Lane Epperstone
    NG14 6BE Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishAccountant18715750002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06. Apr. 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom (England)
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer06898191
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 27. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Price
    Transaktionen
    • 27. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 20. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Matthew Paul Ramsbottom
    Transaktionen
    • 20. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 29. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 20. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert John Norman
    Transaktionen
    • 20. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 18. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Geoffrey Percy
    Transaktionen
    • 18. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 13. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Global Radio Group Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Philip Riley
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Antony Thomas Lloyd
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 05. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An accession deed
    Erstellt am 02. Juli 2008
    Geliefert am 09. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for and on Behalf of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 09. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An accession deed
    Erstellt am 31. Juli 2007
    Geliefert am 03. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All investments all plant and machinery the insurances all debts the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Consideration letter between the company and the governor and company of the bank of scotland (in its capacity as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries ("the security trustee")
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 08. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys as at 21 april 2000 or at any time thereafter owing to the security trustee and security beneficiaries by the principal debtors or any of them (where any company is also a principal debtor, the liability of such company to the security beneficiaries under the deed shall only have effect in relation to all the other principal debtors) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Geliefert am 09. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0