CIM MANAGEMENT 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CIM MANAGEMENT 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03050683 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Whittington Hall Whittington Road, Whittington WR5 2ZX Worcester Worcestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CIM MANAGEMENT LIMITED | 17. Apr. 2009 | 17. Apr. 2009 |
| CIM MANAGEMENT 2 LIMITED | 11. Juni 2008 | 11. Juni 2008 |
| CIM MANAGEMENT LIMITED | 28. Sept. 1995 | 28. Sept. 1995 |
| MOONSTRUCK LIMITED | 27. Apr. 1995 | 27. Apr. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Aug. 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Charles Annetts als Geschäftsführer am 01. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Duncan James Moore als Direktor am 31. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Andrew Reynolds am 09. Nov. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMBERSTONE (SECRETARIES) LIMITED | Sekretär | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire United Kingdom |
| 77906620001 | ||||||||||
| BARKER, Andrew Martin | Geschäftsführer | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 149813130009 | |||||||||
| MOORE, Duncan James | Geschäftsführer | Whittington Hall Whittington Road, Whittington WR5 2ZX Worcester Worcestershire | England | British | 78671940006 | |||||||||
| REYNOLDS, Mark Andrew | Geschäftsführer | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 41446640003 | |||||||||
| ANNETTS, David Charles | Sekretär | The Snead Pensax WR6 6AG Abberley Worcestershire | British | 81373880001 | ||||||||||
| MURPHY, Michael Joseph | Sekretär | 6 Barwick Road Up Hatherley GL51 5UY Cheltenham Gloucestershire | British | 31259900001 | ||||||||||
| ROGERS, Helen Frances Leigh | Sekretär | 6 Severn Way GL19 4DA Apperley Gloucestershire | British | 73814460001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||||||
| ANNETTS, David Charles | Geschäftsführer | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 81373880001 | |||||||||
| ANNETTS, David Charles | Geschäftsführer | The Snead Pensax WR6 6AG Abberley Worcestershire | United Kingdom | British | 81373880001 | |||||||||
| BARKER, Andrew Martin | Geschäftsführer | Upper Birch Farm Shatterford DY12 1TR Bewdley Worcestershire | British | 54622310001 | ||||||||||
| BRUCKLAND, Andrew John | Geschäftsführer | 18 Eldorado Road GL50 2PT Cheltenham Gloucestershire | England | British | 22103780002 | |||||||||
| UNDERHILL, Peter John | Geschäftsführer | Maes Court Knighton On Teme WR15 8LY Tenbury Wells Worcestershire | British | 17203000001 | ||||||||||
| PEMBERSTONE (DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire United Kingdom |
| 82038280001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds | 900005000001 | |||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pgl (201) Limited | 06. Apr. 2016 | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CIM MANAGEMENT 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 03. Juni 1999 Geliefert am 21. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999 | |
Kurze Angaben The property known as rutherford house blackploe road worcester title number HW155958. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Juni 1999 Geliefert am 21. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. Juni 1999 Geliefert am 11. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Mai 1998 Geliefert am 28. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a rutherford house blackpole road worcester.t/no.HW155958.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 23. Feb. 1996 Geliefert am 05. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0