UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03052147 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 4 Gravelly Industrial Estate B24 8HZ Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PLAYERHOBBY LIMITED | 02. Mai 1995 | 02. Mai 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2020 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 030521470003, erstellt am 28. Okt. 2020 | 33 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2019 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 19. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2018 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Arran Peter Fewkes am 21. Juni 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Arran Peter Fewkes am 14. März 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 583 Moseley Road Birmingham West Midlands B12 9BG zum Unit 4 Gravelly Industrial Estate Birmingham B24 8HZ am 13. Nov. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Change of details for Seckloe 302 Limited as a person with significant control on 01. Okt. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steve Fleming als Geschäftsführer am 26. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Arran Peter Fewkes am 07. Mai 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Steve Fleming am 07. Mai 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse C/O Emw Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEWKES, Arran Peter | Geschäftsführer | Gravelly Industrial Estate B24 8HZ Birmingham Unit 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 208666380001 | |||||
| VICARY, Gary Kevin | Geschäftsführer | Dunstan Lane CH64 8TG Burton Dunstan Wood Cheshire United Kingdom | England | British | 18943850007 | |||||
| JONES, Stuart William | Sekretär | The Granary Park Farm Barns Crutch Lane, Elmbridge WR9 0BG Droitwich Worcestershire | British | 67350310001 | ||||||
| VICARY, Gary Kevin | Sekretär | Desborough Manorial Road Parkgate CH64 6QN Neston Wirral | British | 18943850005 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| COWAN, Peter Lawrence | Geschäftsführer | The Lodge Brooks Drive Hale Barns WA15 8TR Altrincham Cheshire | British | 42077520002 | ||||||
| DIGGINES, Jonathan Brett | Geschäftsführer | Rossways 32 Broad Lane WA15 0DH Hale Cheshire | British | 80119110001 | ||||||
| FLEMING, Steven Glenn | Geschäftsführer | Moseley Road B12 9BL Birmingham 583 West Midlands United Kingdom | England | British | 268163700001 | |||||
| FOREMAN, Jonathan Richard William | Geschäftsführer | 61 Scholars Green Lane WA13 0PS Lymm Cheshire | British | 52699370002 | ||||||
| JONES, Stuart William | Geschäftsführer | The Granary Park Farm Barns Crutch Lane, Elmbridge WR9 0BG Droitwich Worcestershire | United Kingdom | British | 67350310001 | |||||
| SHINDLER, Geoffrey Arnold | Geschäftsführer | 10 Bury Old Road Prestwich M25 0EX Manchester | England | British | 19609080002 | |||||
| THOMAS, Barbara, Lady | Geschäftsführer | St James's Street SW1A 1HD London 33 | American | 88709030001 | ||||||
| TOWNSEND, Neil | Geschäftsführer | 1 Hornsmill Way WA6 0DE Helsby Cheshire | United Kingdom | British | 115072900001 | |||||
| TYLER, Christopher | Geschäftsführer | 116 Royal Worcester Crescent B60 2TR Bromsgrove Worcestershire | United Kingdom | British | 67350330003 | |||||
| VICARY, Gary Kevin | Geschäftsführer | Desborough Manorial Road Parkgate CH64 6QN Neston Wirral | British | 18943850005 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seckloe 302 Limited | 06. Apr. 2016 | Gravelly Industrial Estate B24 8HZ Birmingham Unit 4 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat UNITED OPTICAL INDUSTRIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 28. Okt. 2020 Geliefert am 20. Nov. 2020 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung By way of fixed charge:. 1. all freehold and leasehold properties (whether registered or unregistered) and all commonhold properties, now or in the future (and from time to time) owned by the borrower, or in which the borrower holds an interest (including, but not limited to, the properties specified in schedule 1) in the future;. 2. all present and future interests of the borrower not effectively mortgaged or charged under the preceding provisions of this clause in, or over, freehold or leasehold property;. 3. all the borrower's present and future patents, trade-marks, service marks, trade names, designs, copyrights, inventions, topographical or similar rights, confidential information and know-how and any interest in any of these rights, whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration and all fees, royalties and other rights derived from, or incidental to, these rights. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 21. Dez. 1998 Geliefert am 23. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Aug. 1995 Geliefert am 12. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0