MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED

MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03059563
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    • (9220) /

    Wo befindet sich MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    13 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Feb. 2017

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Feb. 2016

    16 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Feb. 2015

    20 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Feb. 2014

    10 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    2.34B

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator ;- s m rayment replaces a h beckingham 15/11/2013
    14 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beendigung der Bestellung von Emmanuelle Namiech als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    15 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Aug. 2012

    15 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Alison Rayson als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    4 Seiten2.23B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    4 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    92 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    14 Seiten2.16B

    Änderung der Details des Direktors für Alison Dawn Rayson am 21. Okt. 2011

    2 SeitenCH01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2Nd Floor Garfield House 86-88 Edgware Road London W2 2EA* am 05. März 2012

    2 SeitenAD01

    legacy

    8 SeitenMG01

    Ernennung von Mrs Emmanuelle Namiech als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    20 SeitenAA

    Ernennung von Mr Mark Andrew Webster als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Miss Deborah Margaret Brown als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROWN, Deborah Margaret
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Sekretär
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    162200060001
    WEBSTER, Mark Andrew
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish165027120001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    FERMAN, David Leonard Paul
    4 Church Farm Close
    Hoo
    ME3 9AY Rochester
    Kent
    Sekretär
    4 Church Farm Close
    Hoo
    ME3 9AY Rochester
    Kent
    British35553740001
    GIBBONS, Nigel
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    Sekretär
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    British39895440002
    KIRBY, Robert Henry
    Shortlands Road
    KT2 6HD Kingston-Upon-Thames
    36
    Surrey
    Sekretär
    Shortlands Road
    KT2 6HD Kingston-Upon-Thames
    36
    Surrey
    British131528280001
    ROBERTS, Jeremy Charles
    14 Perryn House
    Bromyard Avenue
    W3 7JD London
    Sekretär
    14 Perryn House
    Bromyard Avenue
    W3 7JD London
    British86671080001
    TAYLOR, Richard George
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    Sekretär
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    British47989960001
    THOM, Alastair Stephen
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    Sekretär
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    British9591260001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    GIBBONS, Nigel
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish39895440002
    HARMAN, Phillip Brent
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    Geschäftsführer
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    New Zealander51102310001
    LIGHTING, Jane Elizabeth Stuart
    Flat 1 2 Holford Road
    Hampstead
    NW3 1AD London
    Geschäftsführer
    Flat 1 2 Holford Road
    Hampstead
    NW3 1AD London
    United KingdomBritish49969850002
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Geschäftsführer
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    NAMIECH, Emmanuelle
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    UkFrench165108170001
    OPIE, Lisa Moreen
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish88563310001
    RAYSON, Alison Dawn
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish139392710003
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Geschäftsführer
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    WALL, Malcolm Robert
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    Geschäftsführer
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    EnglandBritish178772080002
    WHEBLE, Anthony
    Oakway House
    5 Birchwood Road
    BR5 1NX Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    Oakway House
    5 Birchwood Road
    BR5 1NX Orpington
    Kent
    British67960870002
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Hat MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2012
    Geliefert am 03. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Metrodome Group PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 24. Jan. 2011
    Geliefert am 28. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 2008
    Geliefert am 27. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 10. Mai 2005
    Geliefert am 18. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the chargors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 18. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 02. März 2000
    Geliefert am 16. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transaktionen
    • 16. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Juni 1995
    Geliefert am 26. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Feb. 2012Beginn der Verwaltung
    28. Feb. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Howard Beckingham
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Shay Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    DatumTyp
    28. Feb. 2013Beginn der Liquidation
    14. Mai 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Howard Beckingham
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0