MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03059563 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?
- (9220) /
Wo befindet sich MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 13 Seiten | LIQ14 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Feb. 2017 | 14 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Feb. 2016 | 16 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Feb. 2015 | 20 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Feb. 2014 | 10 Seiten | 4.68 | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 2.34B | |||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:replacement of liquidator ;- s m rayment replaces a h beckingham 15/11/2013 | 14 Seiten | LIQ MISC OC | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||
Beendigung der Bestellung von Emmanuelle Namiech als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 15 Seiten | 2.34B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Aug. 2012 | 15 Seiten | 2.24B | ||
Beendigung der Bestellung von Alison Rayson als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 4 Seiten | 2.23B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 4 Seiten | 2.23B | ||
Vorschlag des Verwalters | 92 Seiten | 2.17B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 14 Seiten | 2.16B | ||
Änderung der Details des Direktors für Alison Dawn Rayson am 21. Okt. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2Nd Floor Garfield House 86-88 Edgware Road London W2 2EA* am 05. März 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||
legacy | 8 Seiten | MG01 | ||
Ernennung von Mrs Emmanuelle Namiech als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 20 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Mark Andrew Webster als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Miss Deborah Margaret Brown als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Deborah Margaret | Sekretär | Baker Street W1U 7EU London 55 | 162200060001 | |||||||
| WEBSTER, Mark Andrew | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | 165027120001 | |||||
| BURNS, Clive | Sekretär | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||
| FERMAN, David Leonard Paul | Sekretär | 4 Church Farm Close Hoo ME3 9AY Rochester Kent | British | 35553740001 | ||||||
| GIBBONS, Nigel | Sekretär | Ockford Wood Farm New Way GU7 2QL Godalming Surrey | British | 39895440002 | ||||||
| KIRBY, Robert Henry | Sekretär | Shortlands Road KT2 6HD Kingston-Upon-Thames 36 Surrey | British | 131528280001 | ||||||
| ROBERTS, Jeremy Charles | Sekretär | 14 Perryn House Bromyard Avenue W3 7JD London | British | 86671080001 | ||||||
| TAYLOR, Richard George | Sekretär | 72 Hall Green Lane Hutton CM13 2QT Brentwood Essex | British | 47989960001 | ||||||
| THOM, Alastair Stephen | Sekretär | 13 The Meadway IG9 5PG Buckhurst Hill Essex | British | 9591260001 | ||||||
| CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000860001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| BURDICK, Charles James | Geschäftsführer | 9 Ormonde Place SW1W 8HX London | British-American | 52311710004 | ||||||
| COOK, Stephen Sands | Geschäftsführer | 24a Redcliffe Square SW10 9JY London | British | 73000530008 | ||||||
| GIBBONS, Nigel | Geschäftsführer | Ockford Wood Farm New Way GU7 2QL Godalming Surrey | United Kingdom | British | 39895440002 | |||||
| HARMAN, Phillip Brent | Geschäftsführer | 1 Cartwright Way Barnes SW13 8HD London | New Zealander | 51102310001 | ||||||
| LIGHTING, Jane Elizabeth Stuart | Geschäftsführer | Flat 1 2 Holford Road Hampstead NW3 1AD London | United Kingdom | British | 49969850002 | |||||
| LUIZ, Mark Walter | Geschäftsführer | 165 Cranley Gardens N10 3AE London | British | 37860010002 | ||||||
| NAMIECH, Emmanuelle | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | Uk | French | 165108170001 | |||||
| OPIE, Lisa Moreen | Geschäftsführer | 6 Millfield HP4 2PB Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 88563310001 | |||||
| RAYSON, Alison Dawn | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | 139392710003 | |||||
| SMITH, Neil Reynolds | Geschäftsführer | Brettwood Green Lane Churt GU10 2PA Farnham Surrey | British | 79956240002 | ||||||
| STENHAM, Anthony William Paul | Geschäftsführer | 4 The Grove Highgate N6 6JU London | British | 8281170001 | ||||||
| WALL, Malcolm Robert | Geschäftsführer | The Close 2 Longfield Drive East Sheen SW14 7AU London | England | British | 178772080002 | |||||
| WHEBLE, Anthony | Geschäftsführer | Oakway House 5 Birchwood Road BR5 1NX Orpington Kent | British | 67960870002 | ||||||
| CHETTLEBURGH'S LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000850001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107430002 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 |
Hat MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2012 Geliefert am 03. Feb. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Jan. 2011 Geliefert am 28. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Feb. 2008 Geliefert am 27. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 10. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 10. Mai 2005 Geliefert am 18. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the chargors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 02. März 2000 Geliefert am 16. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 19. Juni 1995 Geliefert am 26. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0