FERFOOT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FERFOOT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03060627 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FERFOOT LIMITED?
- Pflegeheime für ältere und behinderte Menschen (87100) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich FERFOOT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street SW1H 0AD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FERFOOT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHORD PROPERTIES LIMITED | 24. Mai 1995 | 24. Mai 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FERFOOT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FERFOOT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 20. Juli 2015 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP zum Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD am 05. Aug. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 01. Jan. 2015 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Ernennung von Jonathan David Farkas als Direktor am 27. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mathieu Streiff als Geschäftsführer am 27. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 28 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 30. März 2014 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mathieu Streiff am 30. März 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* am 07. Apr. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2014 bis 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FERFOOT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Sekretär | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England |
| 175738460001 | ||||||||||
| FARKAS, Jonathan David | Geschäftsführer | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor | Luxembourg | American | 193539990001 | |||||||||
| BARTON, Amanda | Sekretär | 48 Sutherland Crescent SN14 6RS Chippenham Wiltshire | British | 44536640002 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Sekretär | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 109044580001 | ||||||||||
| CRS LEGAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Newfoundland Chambers 43a Whitchurch Road CF4 3JN Cardiff South Glamorgan | 900004280001 | |||||||||||
| BARTON, Amanda | Geschäftsführer | 48 Sutherland Crescent SN14 6RS Chippenham Wiltshire | British | 44536640002 | ||||||||||
| BARTON, Bridget Ann | Geschäftsführer | Turnpike Cottage Old Hardenhuish Lane SN14 6HH Chippenham Wiltshire | British | 44536190001 | ||||||||||
| BARTON, Henry Robin (Dick), Major | Geschäftsführer | Ferfoot Old Hardenhuish Lane SN14 6HH Chippenham Wiltshire | British | 38548600001 | ||||||||||
| GRIFFIN, Craig | Geschäftsführer | Halebourne House Halebourne Lane GU24 8SL Chobham Surrey | United Kingdom | British | 154122490001 | |||||||||
| HILL, Peter Martin | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 130983750002 | |||||||||
| JEFFERY, Paul Anthony Keith | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 65609290003 | |||||||||
| NOVIK, Bridget Christina | Geschäftsführer | 37 Frogwell Park SN14 0RB Chippenham Wiltshire | British | 44536160002 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 148139420001 | |||||||||
| STREIFF, Mathieu Bernard | Geschäftsführer | c/o Sanne Group 10 Cork Street W1S 3NP London 2nd Floor Pollen House | United States | American | 200529310001 | |||||||||
| WHITE, Ian James | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 133383410003 | |||||||||
| MC FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Newfoundland Chambers 43a Whitchurch Road CF4 3JN Cardiff South Glamorgan | 900004800001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FERFOOT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited | 06. Apr. 2016 | 2nd Floor, 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FERFOOT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 2010 Geliefert am 06. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2007 Geliefert am 27. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party debenture | Erstellt am 07. Dez. 2006 Geliefert am 19. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the debtor to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Jan. 2004 Geliefert am 29. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ferfoot old hardenhuish lane chippenham wiltshire t/no WT147273. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Dez. 2003 Geliefert am 10. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 26. Okt. 1995 Geliefert am 10. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the policies of life insurance no. 2774432 and 2774436. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. Okt. 1995 Geliefert am 10. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at ferfoot old hardenhuish lane chippenham wilts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0