BRETTS (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRETTS (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03064951 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRETTS (HOLDINGS) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich BRETTS (HOLDINGS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Parkwood Sutton Road ME15 9NE Maidstone England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRETTS (HOLDINGS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRETTS (HOLDINGS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 13 Craven Street London WC2N 5PB England zum 23 Kings Hill Avenue Kings Hill West Malling ME19 4UA geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Notification of S G Court Limited as a person with significant control on 07. Nov. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Philip Joseph Brown as a person with significant control on 07. Nov. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Patricia Mary Brown as a person with significant control on 07. Nov. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Warren House Warren Road Kingston upon Thames Surrey KT2 7HY zum Parkwood Sutton Road Maidstone ME15 9NE am 08. Nov. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Victoria Kathleen Louise Good als Geschäftsführer am 07. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Oliver Liam O'callaghan-Brown als Geschäftsführer am 07. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patricia Mary Brown als Geschäftsführer am 07. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patricia Mary Brown als Sekretär am 07. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Ms Alison Ware als Sekretär am 07. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Patrick Mcconville als Direktor am 07. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Joseph Brown als Geschäftsführer am 23. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 19 Craven Street London WC2N 5PB United Kingdom zum 13 Craven Street London WC2N 5PB geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRETTS (HOLDINGS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARE, Alison | Sekretär | Sutton Road ME15 9NE Maidstone Parkwood England | 218048310001 | |||||||
| MCCONVILLE, John Patrick | Geschäftsführer | 40 Hillydeal Road Otford TN14 5RU Sevenoaks The Old Pump House England | England | British | 214500770001 | |||||
| BROWN, Patricia Mary | Sekretär | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | British | 3829080005 | ||||||
| RODWELL, Elizabeth Jane | Sekretär | Stonybank 87 The Street Crowmarsh Gifford OX10 8EF Wallingford Oxfordshire | British | 43519180002 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| BROWN, Patricia Mary | Geschäftsführer | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | England | British | 3829080005 | |||||
| BROWN, Philip Joseph, Dr | Geschäftsführer | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | England | British | 99033870001 | |||||
| GOOD, Victoria Kathleen Louise | Geschäftsführer | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | England | British | 188389200001 | |||||
| O'CALLAGHAN-BROWN, Oliver Liam | Geschäftsführer | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | England | British | 191308240001 | |||||
| RODWELL, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | Stonybank 87 The Street Crowmarsh Gifford OX10 8EF Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 43519180002 | |||||
| RODWELL, Paul Robert | Geschäftsführer | 87 The Street Crowmarsh Gifford OX10 8EF Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 53895920001 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BRETTS (HOLDINGS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S G Court Limited | 07. Nov. 2016 | Sutton Road ME15 9NE Maidstone Parkwood England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mrs Patricia Mary Brown | 06. Apr. 2016 | Sutton Road ME15 9NE Maidstone Parkwood England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Dr Philip Joseph Brown | 06. Apr. 2016 | Sutton Road ME15 9NE Maidstone Parkwood England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BRETTS (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 06. Aug. 2008 Geliefert am 14. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the interest in the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Aug. 2008 Geliefert am 12. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 25C high street stanford in the vale faringdon, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 2004 Geliefert am 02. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2-3 high street ashley heath ringwood. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Nov. 2000 Geliefert am 16. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 11 & 12 millbrook square grove wantage oxfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Sept. 2000 Geliefert am 05. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Juli 1997 Geliefert am 31. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0