DEANWATER ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDEANWATER ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03065400
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DEANWATER ESTATES LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich DEANWATER ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DEANWATER ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GOOCH WEBSTER LIMITED01. Mai 199801. Mai 1998
    J TREVOR & WEBSTER LIMITED24. Okt. 199524. Okt. 1995
    CONTINENTAL SHELF 27 LIMITED07. Juni 199507. Juni 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEANWATER ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DEANWATER ESTATES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für DEANWATER ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 Seiten4.72

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Apr. 2013

    31 Seiten2.24B

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Apr. 2014

    21 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. März 2013

    31 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012

    30 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012

    30 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012

    27 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012

    28 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    legacy

    3 SeitenMG04

    Beendigung der Bestellung von Mark Sample als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Mcfarlane als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    59 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B

    8 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 9 Marylebone Lane London W1U 1HL* am 04. Apr. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 17. Mai 2011

    • Kapital: GBP 500,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von David Izett als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mark John Sample am 28. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew James Mcfarlane am 28. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von DEANWATER ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOLDSOBEL, Howard
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Sekretär
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British57132180002
    ASHBY, Anthony Clifford
    1 Thirlmere Gardens
    HA6 2RS Northwood
    Middlesex
    Sekretär
    1 Thirlmere Gardens
    HA6 2RS Northwood
    Middlesex
    British51998620001
    HICKEY, Teritia Josine
    92 Churchbury Road
    Eltham
    SE9 5HZ London
    Sekretär
    92 Churchbury Road
    Eltham
    SE9 5HZ London
    British76847670001
    KING, Andrew Peter
    26 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    Sekretär
    26 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    British120550750001
    LEWIS, Thomas Frederick
    25 South View Drive
    E18 1NP London
    Sekretär
    25 South View Drive
    E18 1NP London
    British119917290001
    MCGREAL, Anne
    Flat 3 63/71 Rye Hill Park
    SE15 3JR London
    Sekretär
    Flat 3 63/71 Rye Hill Park
    SE15 3JR London
    British49118810001
    RUTTER, John Maddern
    Watermill Farm
    Hazel End
    CM24 8TP Stansted
    Essex
    Sekretär
    Watermill Farm
    Hazel End
    CM24 8TP Stansted
    Essex
    British84226060001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Bevollmächtigter Sekretär
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BELL, Michael Hugh
    72 Church Road
    GU51 4LY Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    72 Church Road
    GU51 4LY Fleet
    Hampshire
    British90062470002
    DOYLE, David Colin
    96 Northchurch Road
    N1 3NY London
    Geschäftsführer
    96 Northchurch Road
    N1 3NY London
    Australian115366000001
    GRAHAM, Andrew Barry
    10 Mulberry Walk
    SW3 6DY London
    Geschäftsführer
    10 Mulberry Walk
    SW3 6DY London
    United KingdomBritish1788740001
    IZETT, David Stewart
    9 Marylebone Lane
    London
    W1U 1HL
    Geschäftsführer
    9 Marylebone Lane
    London
    W1U 1HL
    United KingdomBritish88030400001
    IZETT, David Stewart
    2 Vicarage Drive
    SW18 8RX London
    Geschäftsführer
    2 Vicarage Drive
    SW18 8RX London
    United KingdomBritish88030400001
    KELLY, Alastair William
    6 Penrith Avenue
    G46 6LU Giffnock
    Geschäftsführer
    6 Penrith Avenue
    G46 6LU Giffnock
    British79163740001
    KIDD, Timothy Guy
    52 Orbel Street
    SW11 3NZ London
    Geschäftsführer
    52 Orbel Street
    SW11 3NZ London
    British9401710001
    LEWIS, Thomas Frederick
    25 South View Drive
    E18 1NP London
    Geschäftsführer
    25 South View Drive
    E18 1NP London
    United KingdomBritish119917290001
    LIVINGSTON, James Fraser
    8 Clairmont Gardens
    Kelvingrove
    G3 7LW Glasgow
    Geschäftsführer
    8 Clairmont Gardens
    Kelvingrove
    G3 7LW Glasgow
    British31010002
    MASON, Lesley Jane
    Russet House
    1 The Paddock
    GU7 1XD Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Russet House
    1 The Paddock
    GU7 1XD Godalming
    Surrey
    British69080370001
    MCFARLANE, Andrew James
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish39119700005
    MCGREAL, Anne
    Flat 3 63/71 Rye Hill Park
    SE15 3JR London
    Geschäftsführer
    Flat 3 63/71 Rye Hill Park
    SE15 3JR London
    British49118810001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    Geschäftsführer
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritish46176700002
    PHILLIPS, John Denis
    66 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HW Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    66 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HW Bromley
    Kent
    Other9401720001
    PHILLIPS, John Denis
    66 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HW Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    66 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HW Bromley
    Kent
    Other9401720001
    REES, Nicholas Guest
    22 Birchitt Road
    Broadway
    S17 4QP Sheffield
    Geschäftsführer
    22 Birchitt Road
    Broadway
    S17 4QP Sheffield
    EnglandBritish47111320001
    ROBERTS, Michael John
    89 Clapham Manor Street
    SW4 6DR London
    Geschäftsführer
    89 Clapham Manor Street
    SW4 6DR London
    British58382400001
    RUTTER, John Maddern
    Watermill Farm
    Hazel End
    CM24 8TP Stansted
    Essex
    Geschäftsführer
    Watermill Farm
    Hazel End
    CM24 8TP Stansted
    Essex
    EnglandBritish84226060001
    SAMPLE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish38199850001
    STYLES, Gregory Sean
    2 The Croft
    Collingham
    LS22 5LG Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 The Croft
    Collingham
    LS22 5LG Wetherby
    West Yorkshire
    British79163440001
    TIDY, Thomas Peter
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    Geschäftsführer
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    United KingdomBritish141619610001
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001

    Hat DEANWATER ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. Apr. 2009
    Geliefert am 09. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Assignment in security
    Erstellt am 03. März 2003
    Geliefert am 19. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights titles benefits and interests of the company whatsoever present and future under or arising out of or evidenced by the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assingment in security
    Erstellt am 03. März 2003
    Geliefert am 19. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rights title benefits and interests of the company whatsoever present and future under or arising out of or evidenced by the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 03. März 2003
    Geliefert am 19. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All securities and their proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 03. März 2003
    Geliefert am 19. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or fitzhardinge PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All securities and their proceeds of sale. All dividends interest and other distributions (whether in cash or in specie and whether of a capital or income nature) declared, paid or made in respect of the securities at any time, all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities at any time whether by way of rights bonus capitalisation conversion exchange pre-emption rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2001
    Geliefert am 27. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 11 december 2000 and
    Erstellt am 04. Apr. 2000
    Geliefert am 20. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property known as unit 1 shawbridge street industrial estate, shawbridge street glasgow.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 11TH december 2000
    Erstellt am 04. Apr. 2000
    Geliefert am 16. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Two rubislaw place aberdeen. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordination deed
    Erstellt am 07. Mai 1999
    Geliefert am 20. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future sums liabilities and obligations of hackremco (no.1462) limited (as "borrower") to the bank arising under or in connection with the senior credit agreement and the other finance documents
    Kurze Angaben
    If any amount of subordinated liabilities is discharged by payment repayment prepayment set-off or in any other manner in contravention of clauses 2.1.1 , 3.2 or 5.2 of the deed the company hall save for permitted payment hold the amount received on trust for the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Depfa Bank Ag
    Transaktionen
    • 20. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordination deed
    Erstellt am 07. Mai 1999
    Geliefert am 19. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future sums liabilities and obligations due or to become due from hackremco (no.1462) limited (the "borrower") to the chargee (the "lender") arising under or in connection with the senior credit agreement (as defined) and the other finance documents (as defined) (the "senior liabilities")
    Kurze Angaben
    If any amount of subordinated liabilities is discharged by payment repayment prepayment set-off or in any other manner in contravention of clauses 2.1.1. 3.2, or 5.2 of the subordination deed the company shall save for permitted payments hold the amount received on trust for the lender. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mable Commercial Funding Limited
    Transaktionen
    • 19. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of shares between,inter alia, the company, lehman brothers holdings PLC, stainton international limited and knights valley limited (the "obligors") and depfa ag, london branch (the "bank")
    Erstellt am 07. Mai 1999
    Geliefert am 20. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the obligors or any other party to a finance document to the chargee under the terms of any of the finance documents
    Kurze Angaben
    First fixed charge over the company's charged assets being all shares and derivative assets and undertakings and includes all rights benefits and sums now or in future accruing to the company in respect of the shares and derivative assets and undertakings and in respect of the company the charged assets are shares owned by the company in respect of the charge and all derivative assets undertakings rights benefits and sums accruing to the company in respect of the shares and derivative assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Depfa Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 20. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juli 1996
    Geliefert am 15. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cgf No 9 Limited
    Transaktionen
    • 15. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Apr. 1996
    Geliefert am 16. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Mai 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 16. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DEANWATER ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. März 2012Beginn der Verwaltung
    09. Apr. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DatumTyp
    11. Sept. 2015Aufgelöst am
    09. Apr. 2013Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Praktiker
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0