DEANWATER ESTATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DEANWATER ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03065400 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DEANWATER ESTATES LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich DEANWATER ESTATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DEANWATER ESTATES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GOOCH WEBSTER LIMITED | 01. Mai 1998 | 01. Mai 1998 |
| J TREVOR & WEBSTER LIMITED | 24. Okt. 1995 | 24. Okt. 1995 |
| CONTINENTAL SHELF 27 LIMITED | 07. Juni 1995 | 07. Juni 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEANWATER ESTATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DEANWATER ESTATES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für DEANWATER ESTATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 20 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Apr. 2013 | 31 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Apr. 2014 | 21 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. März 2013 | 31 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012 | 30 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012 | 30 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012 | 27 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Sept. 2012 | 28 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Sample als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Mcfarlane als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 59 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 8 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 9 Marylebone Lane London W1U 1HL* am 04. Apr. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Izett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark John Sample am 28. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew James Mcfarlane am 28. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DEANWATER ESTATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDSOBEL, Howard | Sekretär | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | British | 57132180002 | ||||||
| ASHBY, Anthony Clifford | Sekretär | 1 Thirlmere Gardens HA6 2RS Northwood Middlesex | British | 51998620001 | ||||||
| HICKEY, Teritia Josine | Sekretär | 92 Churchbury Road Eltham SE9 5HZ London | British | 76847670001 | ||||||
| KING, Andrew Peter | Sekretär | 26 Chivalry Road SW11 1HT London | British | 120550750001 | ||||||
| LEWIS, Thomas Frederick | Sekretär | 25 South View Drive E18 1NP London | British | 119917290001 | ||||||
| MCGREAL, Anne | Sekretär | Flat 3 63/71 Rye Hill Park SE15 3JR London | British | 49118810001 | ||||||
| RUTTER, John Maddern | Sekretär | Watermill Farm Hazel End CM24 8TP Stansted Essex | British | 84226060001 | ||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
| BELL, Michael Hugh | Geschäftsführer | 72 Church Road GU51 4LY Fleet Hampshire | British | 90062470002 | ||||||
| DOYLE, David Colin | Geschäftsführer | 96 Northchurch Road N1 3NY London | Australian | 115366000001 | ||||||
| GRAHAM, Andrew Barry | Geschäftsführer | 10 Mulberry Walk SW3 6DY London | United Kingdom | British | 1788740001 | |||||
| IZETT, David Stewart | Geschäftsführer | 9 Marylebone Lane London W1U 1HL | United Kingdom | British | 88030400001 | |||||
| IZETT, David Stewart | Geschäftsführer | 2 Vicarage Drive SW18 8RX London | United Kingdom | British | 88030400001 | |||||
| KELLY, Alastair William | Geschäftsführer | 6 Penrith Avenue G46 6LU Giffnock | British | 79163740001 | ||||||
| KIDD, Timothy Guy | Geschäftsführer | 52 Orbel Street SW11 3NZ London | British | 9401710001 | ||||||
| LEWIS, Thomas Frederick | Geschäftsführer | 25 South View Drive E18 1NP London | United Kingdom | British | 119917290001 | |||||
| LIVINGSTON, James Fraser | Geschäftsführer | 8 Clairmont Gardens Kelvingrove G3 7LW Glasgow | British | 31010002 | ||||||
| MASON, Lesley Jane | Geschäftsführer | Russet House 1 The Paddock GU7 1XD Godalming Surrey | British | 69080370001 | ||||||
| MCFARLANE, Andrew James | Geschäftsführer | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 39119700005 | |||||
| MCGREAL, Anne | Geschäftsführer | Flat 3 63/71 Rye Hill Park SE15 3JR London | British | 49118810001 | ||||||
| PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Geschäftsführer | 17 Greenfield Drive Fortes Green N2 9AF London | England | British | 46176700002 | |||||
| PHILLIPS, John Denis | Geschäftsführer | 66 Hayes Hill Hayes BR2 7HW Bromley Kent | Other | 9401720001 | ||||||
| PHILLIPS, John Denis | Geschäftsführer | 66 Hayes Hill Hayes BR2 7HW Bromley Kent | Other | 9401720001 | ||||||
| REES, Nicholas Guest | Geschäftsführer | 22 Birchitt Road Broadway S17 4QP Sheffield | England | British | 47111320001 | |||||
| ROBERTS, Michael John | Geschäftsführer | 89 Clapham Manor Street SW4 6DR London | British | 58382400001 | ||||||
| RUTTER, John Maddern | Geschäftsführer | Watermill Farm Hazel End CM24 8TP Stansted Essex | England | British | 84226060001 | |||||
| SAMPLE, Mark John | Geschäftsführer | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 38199850001 | |||||
| STYLES, Gregory Sean | Geschäftsführer | 2 The Croft Collingham LS22 5LG Wetherby West Yorkshire | British | 79163440001 | ||||||
| TIDY, Thomas Peter | Geschäftsführer | 24 Handel Mansions 94 Wyatt Drive SW13 8AH London | United Kingdom | British | 141619610001 | |||||
| MD DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow Pacific House | 900005100001 |
Hat DEANWATER ESTATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Apr. 2009 Geliefert am 09. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment in security | Erstellt am 03. März 2003 Geliefert am 19. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights titles benefits and interests of the company whatsoever present and future under or arising out of or evidenced by the secured property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assingment in security | Erstellt am 03. März 2003 Geliefert am 19. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Rights title benefits and interests of the company whatsoever present and future under or arising out of or evidenced by the secured property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 03. März 2003 Geliefert am 19. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All securities and their proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 03. März 2003 Geliefert am 19. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or fitzhardinge PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All securities and their proceeds of sale. All dividends interest and other distributions (whether in cash or in specie and whether of a capital or income nature) declared, paid or made in respect of the securities at any time, all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities at any time whether by way of rights bonus capitalisation conversion exchange pre-emption rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2001 Geliefert am 27. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 11 december 2000 and | Erstellt am 04. Apr. 2000 Geliefert am 20. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property known as unit 1 shawbridge street industrial estate, shawbridge street glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 11TH december 2000 | Erstellt am 04. Apr. 2000 Geliefert am 16. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Two rubislaw place aberdeen. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination deed | Erstellt am 07. Mai 1999 Geliefert am 20. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future sums liabilities and obligations of hackremco (no.1462) limited (as "borrower") to the bank arising under or in connection with the senior credit agreement and the other finance documents | |
Kurze Angaben If any amount of subordinated liabilities is discharged by payment repayment prepayment set-off or in any other manner in contravention of clauses 2.1.1 , 3.2 or 5.2 of the deed the company hall save for permitted payment hold the amount received on trust for the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination deed | Erstellt am 07. Mai 1999 Geliefert am 19. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future sums liabilities and obligations due or to become due from hackremco (no.1462) limited (the "borrower") to the chargee (the "lender") arising under or in connection with the senior credit agreement (as defined) and the other finance documents (as defined) (the "senior liabilities") | |
Kurze Angaben If any amount of subordinated liabilities is discharged by payment repayment prepayment set-off or in any other manner in contravention of clauses 2.1.1. 3.2, or 5.2 of the subordination deed the company shall save for permitted payments hold the amount received on trust for the lender. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of shares between,inter alia, the company, lehman brothers holdings PLC, stainton international limited and knights valley limited (the "obligors") and depfa ag, london branch (the "bank") | Erstellt am 07. Mai 1999 Geliefert am 20. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors or any other party to a finance document to the chargee under the terms of any of the finance documents | |
Kurze Angaben First fixed charge over the company's charged assets being all shares and derivative assets and undertakings and includes all rights benefits and sums now or in future accruing to the company in respect of the shares and derivative assets and undertakings and in respect of the company the charged assets are shares owned by the company in respect of the charge and all derivative assets undertakings rights benefits and sums accruing to the company in respect of the shares and derivative assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Juli 1996 Geliefert am 15. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Apr. 1996 Geliefert am 16. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DEANWATER ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0