CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD

CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03067279
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD?

    • (4521) /

    Wo befindet sich CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Cambridge House
    27 Cambridge Park
    E11 2PU Wanstead
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CAMELOT PROPERTY (WOODBRIDGE) LIMITED12. Juni 199512. Juni 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Auflösungsaufschub

    1 SeitenL64.04

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    legacy

    1 SeitenLQ02

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten405(1)

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2007

    7 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2006

    7 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2005

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2004

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    6 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCKENNON, Robert Baron
    2 Braintree Road
    Felsted
    CM6 3DW Dunmow
    Essex
    Sekretär
    2 Braintree Road
    Felsted
    CM6 3DW Dunmow
    Essex
    British116472480001
    MCKENNON, Gary Robert
    Struts Farm Estates Office
    Parsons Hill Great Bromley
    CO7 7JF Colchester
    Geschäftsführer
    Struts Farm Estates Office
    Parsons Hill Great Bromley
    CO7 7JF Colchester
    EnglandBritish44080940003
    MCKENNON, Gary Robert
    Struts Farm Estates Office
    Parsons Hill Great Bromley
    CO7 7JF Colchester
    Sekretär
    Struts Farm Estates Office
    Parsons Hill Great Bromley
    CO7 7JF Colchester
    British44080940003
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Bevollmächtigter Sekretär
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    BROWN, Edward Charles
    6 Temple Court
    CO4 4PR Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    6 Temple Court
    CO4 4PR Colchester
    Essex
    British44329370001
    MCKENNON, Robert Baron
    18 Chestnut Walk
    CMB 3EJ Felsted
    Essex
    Geschäftsführer
    18 Chestnut Walk
    CMB 3EJ Felsted
    Essex
    British44080900003
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    Hat CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 03. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Marine mortgage
    Erstellt am 11. Juli 2005
    Geliefert am 20. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64 shares in the ship princess V42 hull no: fr-IRI00003H405 official name: advocate of harwich official number 910004 and in its appurtenaces.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 21. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at pierrefitte way braintree t/n EX637629. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 4
    Marine mortgage
    Erstellt am 18. Nov. 2004
    Geliefert am 24. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £193,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Princess V42 hull no.GB PY1 42249J405.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 04. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as 109 high street braintree essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a plotb land at cats lane (near maldon grey public house) sudbury suffolk t/n SK223091. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 3
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Aug. 2001
    Geliefert am 24. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a land adjacent to the maldon grey public house cats lane sudbury suffolk t/n SK167341. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 208. Okt. 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 2
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Mai 2001
    Geliefert am 24. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a former builders yard st michaels road braintree essex t/n EX635477. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Mai 2001
    Geliefert am 23. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at strutts farm (plot 1) frating road great bromley essex. T/no. Part of EX542114 & EX542115. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Mai 2001
    Geliefert am 19. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 12 west stockwell street colchester essex. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Apr. 2001
    Geliefert am 04. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as land adjacent to the maldon grey public house cats lane sudbury suffolk title number SK167341. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Okt. 2000
    Geliefert am 02. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property known as 23 darwin close, birch glen, colchester, essex, title number ex 303053. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 31. Juli 2000
    Geliefert am 15. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights and interest in the agreement dated 21 june 2000 and and all interest in the f/h land having frontage of 164 feet to cats lane great cornard sudbury suffolk all interest in all contracts all machinery and fixtures and fittings all furnishings equipment tools and other chattels the proceeds of any insurance from time to time.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Jan. 1999
    Geliefert am 19. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a garage premises on the north side of nunns road colchester essex. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Jan. 1999
    Geliefert am 19. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and premises on the north side of nunns road colchester essex t/nos: EX450971 and EX555889. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Juni 1998
    Geliefert am 09. Juli 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 60 ballington street sudbury suffolk. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on cash deposit
    Erstellt am 26. Jan. 1998
    Geliefert am 30. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 25TH september 1997
    Kurze Angaben
    All the company's right titke and interest in and to the deposit of £4,000.
    Berechtigte Personen
    • Granville Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge pursuant to an order of court dated 27TH february 1998
    Erstellt am 22. Dez. 1997
    Geliefert am 03. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land on the east side of cats lane great cornard suffolk and a floating charge over all assets property and undertaking including the goodwill and uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Granville Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge pursuant to an order of court dated 27TH february 1998
    Erstellt am 22. Dez. 1997
    Geliefert am 03. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 28 brighton road holland-on-sea essex and a floating charge over all assets property and undertaking including all goodwill and uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Granville Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Juli 1997
    Geliefert am 29. Juli 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2 pettley gardens romford essex. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)

    Hat CAMELOT PROPERTY (HOLDINGS) LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Nov. 2008Antragsdatum
    20. Mai 2016Abschluss der Liquidation
    14. Jan. 2009Beginn der Liquidation
    12. Mai 2018Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathan Howard Gershinson
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Receiver Manager
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Ania Packman
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Receiver Manager
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathan Howard Gershinson
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Receiver Manager
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Ania Packman
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Receiver Manager
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Louisa Jane Brooks
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Receiver Manager
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Jonathan Howard Gershinson
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Receiver Manager
    27 Soho Square
    W1D 3AY London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0