FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03074331 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Norcliffe House Station Road SK9 1BU Wilmslow |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OMEGA (UK) LIMITED | 26. Juni 1995 | 26. Juni 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian Richard Smith am 19. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Benjamin Robert Taberner am 18. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Jude Kay als Geschäftsführer am 28. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Kay als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Abigail Mattison als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maureen Claire Royston am 22. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* am 21. Feb. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Maureen Claire Royston als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Calveley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Richard Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTISON, Abigail | Sekretär | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188573200001 | |||||||
| ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Geschäftsführer | Alderley Road Wilmslow SK9 1NX Cheshire Emerson Court England England | United Kingdom | British | 184190020002 | |||||
| SMITH, Ian Richard | Geschäftsführer | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 181082310001 | |||||
| TABERNER, Benjamin Robert | Geschäftsführer | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 150511890001 | |||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Sekretär | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| GOSLING, Mark David | Sekretär | 8 Dane Close Hartlip ME9 7TN Sittingbourne Kent | British | 66801660001 | ||||||
| KAY, Dominic Jude | Sekretär | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | 145920530001 | ||||||
| CMM (SECRETARIES) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Sceptre House 169/173 Regent Street W1R 7FB London | 900004970001 | |||||||
| SCEPTRE CONSULTANTS LIMITED | Sekretär | 6 Babmaes Street SW1Y 6HD London | 32627710003 | |||||||
| ANSTEAD, Hamilton Douglas | Geschäftsführer | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | 107751890001 | ||||||
| BAILEY, Essel | Geschäftsführer | 900 Victors Way Suite 350 Ann Arbor Mi 48108 Usa | American | 55075420002 | ||||||
| BEARDSLEY, Julian Richard | Geschäftsführer | Flat 2 27 Moring Road SW17 8DN London | British | 67039610001 | ||||||
| CALVELEY, Peter, Dr | Geschäftsführer | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | 131468590001 | |||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Geschäftsführer | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| ELLIOTT, Graham Nicholas | Geschäftsführer | 9 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | England | British | 38064300002 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Geschäftsführer | 28 Harley House Marylebone Road NW1 5HF London | American | 52843400002 | ||||||
| GOSLING, Mark David | Geschäftsführer | 8 Dane Close Hartlip ME9 7TN Sittingbourne Kent | British | 66801660001 | ||||||
| HEYWOOD, Anthony George | Geschäftsführer | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | 131288260001 | |||||
| KAY, Dominic Jude | Geschäftsführer | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | 145920530001 | |||||
| MAYNARD, Tanya | Geschäftsführer | 14 Bayham Road Chiswick W4 1BJ London | British | 41493210001 | ||||||
| MITCHELL, Nicholas John | Geschäftsführer | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | 145102120001 | |||||
| NOBLE, Edward Charles | Geschäftsführer | 9668 Tree Top Court Pickney FOREIGN Michigan Usa | American | 69199980002 | ||||||
| ROBINSON, Todd Philip | Geschäftsführer | 2307 Princess Ann Street Greensboro North Carolina 27408 Usa | American | 77491610001 | ||||||
| STOREY, John | Geschäftsführer | 17 Collins Street SE3 0UG London | British | 60123860001 | ||||||
| STOVER, David | Geschäftsführer | 905 West Eisenhower Circle Suite 110 48103 Ann Arbor Michigan Washtenaw County Usa | American | 55075550001 | ||||||
| WILLIS, Graeme | Geschäftsführer | 4 Woodbank Lynton Lane SK9 7NP Alderley Edge Cheshire | British | 71527500004 |
Hat FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Scottish floating charge | Erstellt am 24. Nov. 2006 Geliefert am 14. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge all its present and future property,assets and undertaking situated in scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security deed | Erstellt am 30. Okt. 2006 Geliefert am 17. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2006 Geliefert am 18. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rhyme debenture | Erstellt am 12. Nov. 2004 Geliefert am 30. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A charge over bank accounts | Erstellt am 03. Juli 2003 Geliefert am 11. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its rights and interests in, and all monies standing to the credit of the account by way of first fixed charge. A floating charge as further security for the payment of the indebtedness, charged with full title guarantee all its rights and interests in, and all monies stnading to the credit of, the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 01. Okt. 2002 Geliefert am 16. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all freehold and leasehold property together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property; and by way of first equitable mortgage all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0