MILLENCO HARDWARE LTD.
Überblick
| Unternehmensname | MILLENCO HARDWARE LTD. |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03075676 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MILLENCO HARDWARE LTD.?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MILLENCO HARDWARE LTD.?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Portebello School Street WV13 3PW Willenhall West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MILLENCO HARDWARE LTD.?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MILLENCO HARDWARE LTD.?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher David Browning am 01. Apr. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung von Christopher David Browning als Direktor am 01. Apr. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Louise Bailey als Geschäftsführer am 31. März 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel John Hutchinson als Geschäftsführer am 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Insolvenzbeschluss Resolution INSOLVENCY:Ordinary Resolution ;- "Books,Records.etc" | 1 Seiten | LIQ MISC RES | ||||||||||
Insolvenzbeschluss Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie" | 1 Seiten | LIQ MISC RES | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Arthur Vann als Geschäftsführer am 01. Juli 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Paddock Fabrications Limited Fryers Road Walsall West Midlands WS2 7LZ am 17. Sept. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Alexander Paul Stern als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Allan David Talbot Cooper als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Claire Louise Bailey als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von John Linley Middleton als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Neil Arthur Vann als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew King als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew King als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MILLENCO HARDWARE LTD.?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STERN, Alexander Paul | Sekretär | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | British | 154212030001 | ||||||
| BROWNING, Christopher David | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | England | British | 177705260001 | |||||
| COOPER, Allan David Talbot | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | United Kingdom | British | 154201290001 | |||||
| MIDDLETON, John Linley | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | United Kingdom | South African | 154201180001 | |||||
| HUNT, Peter Dennis | Sekretär | 97 Dovehouse Lane Olton B91 2EQ Solihull West Midlands | British | 13305530002 | ||||||
| KING, Andrew Mark | Sekretär | 23 Yew Croft Avenue Harborne B17 9TR Birmingham West Midlands | British | 96568110001 | ||||||
| PRIEST, David | Sekretär | 40 Langland Drive DY3 3TH Dudley West Midlands | British | 62678310001 | ||||||
| WILSON, Michael | Sekretär | 15 Brunnel Grove Perton WV6 7YD Wolverhampton West Midlands | British | 19302860003 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BAILEY, Claire Louise | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | United Kingdom | British | 154201050001 | |||||
| BROMLEY, Mark | Geschäftsführer | 3 Ashtree Close Little Haywood ST18 0NL Stafford | British | 40212890001 | ||||||
| BURNHOPE, Mark Edward | Geschäftsführer | 113 Stafford Road Bloxwich WS3 3PG Walsall West Midlands | England | English | 60709550001 | |||||
| HARVEY, Ian James | Geschäftsführer | The Granary Mill Court Mill Lane WS14 0DE Shenstone Staffordshire | British | 71647700003 | ||||||
| HARVEY, Richard Horace | Geschäftsführer | Long Birch Farm, Port Lane Coven WV9 5BE Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 16753430002 | |||||
| HUNT, Peter Dennis | Geschäftsführer | 97 Dovehouse Lane Olton B91 2EQ Solihull West Midlands | England | British | 13305530002 | |||||
| HUTCHINSON, Nigel John | Geschäftsführer | 1 Penkside Coven WV9 5BL Wolverhampton | United Kingdom | British | 63848530002 | |||||
| KING, Andrew Mark | Geschäftsführer | 23 Yew Croft Avenue Harborne B17 9TR Birmingham West Midlands | England | British | 96568110001 | |||||
| LOFTUS, Thomas | Geschäftsführer | 29 Canalside Close Penkridge ST19 5TX Stafford | British | 36166430003 | ||||||
| VANN, Neil Arthur | Geschäftsführer | School Street WV13 3PW Willenhall Portebello West Midlands | United Kingdom | British | 154201650001 | |||||
| WILSON, Michael | Geschäftsführer | 15 Brunnel Grove Perton WV6 7YD Wolverhampton West Midlands | British | 19302860003 |
Hat MILLENCO HARDWARE LTD. Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 08. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 04. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of intellectual property rights | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 04. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the intellectual property rights, assigns all applications and all right title and interest in and to the applications, all right title and interest in and to all those third party rights and by way of fixed charge such part of the materials. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. März 2005 Geliefert am 30. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Juli 2002 Geliefert am 22. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Juli 1996 Geliefert am 12. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MILLENCO HARDWARE LTD. Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0