FLEETS POINT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FLEETS POINT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03075946 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FLEETS POINT LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FLEETS POINT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | BARRY BROOMBERG OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLP Fleet Point Verde 10 Bressenden Place SW1E 5DH London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FLEETS POINT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FITNESS FIRST LIMITED | 18. Aug. 2003 | 18. Aug. 2003 |
| FITNESS FIRST PLC | 23. Sept. 1996 | 23. Sept. 1996 |
| FITNESS FIRST GROUP LIMITED | 29. Juni 1995 | 29. Juni 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEETS POINT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FLEETS POINT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Barry Alan Broomberg als Geschäftsführer am 31. Mai 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2022 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Barry Alan Broomberg am 18. Nov. 2019 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Verde Bressenden Place London SW1E 5DH England zum Fleet Point 10 Bressenden Place London SW1E 5DH am 17. Dez. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Richard Stevens als Geschäftsführer am 20. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 34 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susan Anne Cadd als Sekretär am 05. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 52 Willis Way Poole BH15 3SY England zum Verde Bressenden Place London SW1E 5DH am 04. Sept. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 030759460023 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 030759460024 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 44 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FLEETS POINT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALFOUR, Michael William | Sekretär | 1belvedere House 6 Mckinley Road BH4 8AQ Bournemouth Dorset | British | 36866470002 | ||||||
| CADD, Susan Anne | Sekretär | Bressenden Place SW1E 5DH London Verde England | British | 82401780001 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| BALFOUR, Michael William | Geschäftsführer | 11 Bury Road BH13 7DD Poole Dorset | British | 36866470005 | ||||||
| BAMFORD, Stephen James | Geschäftsführer | Glengarden Farmleigh Grove Burwood Park KT12 5BU Walton On Thames Surrey | British | 47964750001 | ||||||
| BICKLE, Justin Andrew | Geschäftsführer | Knightsbridge SW1X 7LY London 27 United Kingdom | England | British | 112506210002 | |||||
| BODDY, Peter Ashley | Geschäftsführer | The Old Rectory Church Hill Road LE16 7SN Cranoe Leicestershire | England | British | 101072960001 | |||||
| BROOMBERG, Barry Alan | Geschäftsführer | Fleet Point Verde 10 Bressenden Place SW1E 5DH London Oaktree Capital Management Llp England | United Kingdom | British | 207557180001 | |||||
| BYNG MADDICK, Zillah | Geschäftsführer | Russet House 14 Claremont Gardens SL7 1BS Slough | England | British | 118619550001 | |||||
| CARTWRIGHT, Nigel Ronald | Geschäftsführer | Staithe The Causeway KT10 0NE Claygate Surrey | United Kingdom | British | 51888080001 | |||||
| CHESTER, Ross | Geschäftsführer | Compass Court 42/44 Winn Road SO17 1EQ Southampton | British | 121959520001 | ||||||
| CHILD, Colin Charles | Geschäftsführer | Waterside House Headbourne Worthy SO23 7JR Winchester Hants | England | British | 125146440001 | |||||
| DENNING, Edward John | Geschäftsführer | Lowder Mill Bell Vale Lane GU27 3DJ Haselmere Surrey | United Kingdom | British | 5755650002 | |||||
| ENOCH, Melvyn Stuart | Geschäftsführer | 9 Aylmer Drive HA7 3EJ Stanmore Middlesex | British | 57420500001 | ||||||
| FEINGOLD, Limor | Geschäftsführer | 23 Elms Avenue BH14 8EE Poole Dorset | British | 109022770001 | ||||||
| FEINGOLD, Limor | Geschäftsführer | 4 Moriconium Quay BH15 4QP Poole Dorset | British | 99858900001 | ||||||
| GOLDSMITH, Walter Kenneth | Geschäftsführer | 21 Ashurst Close HA6 1EL Northwood Middlesex | British | 10845240002 | ||||||
| GUSCOTT, Malcolm Sinclair | Geschäftsführer | 6 Mckinley Road BH4 8AQ Bournemouth Dorset | British | 47529000005 | ||||||
| KENGELBACH, Jan | Geschäftsführer | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | England | German | 166791090001 | |||||
| LIGHT, Craig Jonathan | Geschäftsführer | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | England | British | 175309730001 | |||||
| MCGOLDRICK, James Edward | Geschäftsführer | Morfelderlandstr 265 FOREIGN Frankfurt 60598 Germany | American | 86450530001 | ||||||
| METCALF, Michael Edward | Geschäftsführer | Tanglewood 19 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | England | British | 61013220001 | |||||
| NEWMAN, Timothy Carlo | Geschäftsführer | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | England | British | 133499820001 | |||||
| NEWMAN, Timothy Carlo | Geschäftsführer | Charlton Marshall DT11 9NE Blandford Newlands Manor House Dorset | England | British | 133499820001 | |||||
| PEARCE, Christopher Donovan James | Geschäftsführer | Pembridge House Pachesham Park KT22 0DJ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 20666800004 | |||||
| PHILLIPS, Sean | Geschäftsführer | 39 Western Avenue Branscote Park BH13 7AN Poole Dorset | American | 44839890004 | ||||||
| STEVENS, Paul Richard | Geschäftsführer | Bressenden Place SW1E 5DH London Verde England | England | British | 186050040001 | |||||
| TATTON-BROWN, Duncan Eden | Geschäftsführer | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | England | British | 149245720001 | |||||
| WAGGETT, Colin Douglas | Geschäftsführer | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | England | British | 104154090003 | |||||
| WARTIG, John Michael | Geschäftsführer | Willis Way BH15 3SY Poole 52 England | England | Australian | 178768810001 | |||||
| WILLIAMS, Jeremy David | Geschäftsführer | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | United Kingdom | British | 121982220002 | |||||
| WILLIAMS, Jeremy David | Geschäftsführer | Witchampton BH21 5AR Wimborne Welcombe Thatch | United Kingdom | British | 121982220002 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FLEETS POINT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moraylimited | 06. Apr. 2016 | Fleets Lane BH15 3BT Poole 58 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FLEETS POINT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 25. Apr. 2014 Geliefert am 06. Mai 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 25. Apr. 2014 Geliefert am 06. Mai 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Sept. 2013 Geliefert am 17. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Sept. 2013 Geliefert am 17. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Trademark id: 36447 country UK reg no 2111128, 43481 country european union reg no 898734, 43481AT country austria reg no 898734, for details of further trademarks please refer to the document image. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 01. Aug. 2012 Geliefert am 07. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All amounts now and in the future credited to account numbers 550/00/31194249 and 28424301 with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Confirmation and amendment agreement | Erstellt am 14. Dez. 2010 Geliefert am 23. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Th shares being the two shares in the amount of eur 25,000.00 and eur 2,475,000.00 together with all ancillary rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 14. März 2008 Geliefert am 26. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A first ranking pledge over the shares and all future shares see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An agreement and deed of pledge of shares | Erstellt am 17. Aug. 2007 Geliefert am 01. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement | Erstellt am 31. Jan. 2006 Geliefert am 13. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charging company pledged to the pledgees all of its shares in the company being the share capital held by the charging company of one share of dem 636,000.00 and the share capital of dem 9,964,000.00 held by pledgor 2 consisting of 9 shares in the nominal amount of dem 62,500.00, dem 12,500.00, dem 905,000.00, dem 12,500.00, dem 37,500.00, dem 770,000.00, dem 990,000.00, dem 520,000.00 and dem 6,654,000.00 (together with any future shares of the pledgors) and all present and future rights attached to the shares.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement and deed of pledge of shares | Erstellt am 31. Jan. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Five thousand issued and outstanding shares numbered 1 up to and including 5000 each with a nominal capital of one hundred euro (eur 100) in the share capital of the company and registered in the name of the charging company and all dividends and distributions in respect of the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement | Erstellt am 31. Jan. 2006 Geliefert am 13. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charging company pledged to the pledgee all of its shares in the company being the share capital of eur 2,500,000.00 of the company consisting of two shares in the amount of eur 25,000.00 and eur 2,475,000.00 held by the charging company (together with any future shares of the charging company after the charge date) and all present and future rights attached to the shares.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 30. Jan. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interest in respect of sums payable pursuant to the insurance policies all rights title and interest in respect of the hedging agreements and all rights title and interest in resp. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share mortgage | Erstellt am 30. Jan. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares the additional rights and the designated account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 30. Jan. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 1,895,316 shares of hk$1 each in the issued share capital of the company and the derivative assets owned by the charging company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 30. Jan. 2006 Geliefert am 10. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The 18,128,482 registered shares in the company owned by the charging company from the pledge date any and all rights to aquire shares in the capital of the company which rights the charging company has at the pledge date and any and all other rights pertaining to the shares from the pledge date including the right to receive all interest and dividend rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Okt. 2003 Geliefert am 21. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Legal mortgage all the land fixed charge all ,plant and machinery, rental and other income, investments, rights under insurances, goodwill and uncalled capital, intellectual property, agreements and licences, trade secrets, confidential information and know-how, rights and causes of action in respect of infringements, book and other debts, claims against third parties, negotiable instruments, claims in any pension fund, monies standing to any realisation account, rights over land, floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 25TH july 2003 and | Erstellt am 24. Juni 2003 Geliefert am 08. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each and any chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the l/h interest in the east side of cathcart road glasgow t/n GLA110299. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share mortgage | Erstellt am 24. Juni 2003 Geliefert am 08. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future shares and new rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 24. Juni 2003 Geliefert am 08. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The security assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and supplemental charge supplemental to a debenture dated 10 april 2003 and | Erstellt am 24. Juni 2003 Geliefert am 04. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the charging company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement | Erstellt am 23. Juni 2003 Geliefert am 14. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent, the company and or all other obligors to the pledgee and/or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All shares of the pledging company including all present and future rights attached to the shares. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 21. Juni 1999 Geliefert am 08. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the financing documents including the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 291298 | Erstellt am 01. Dez. 1998 Geliefert am 07. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The tenant's interest under the lease between the city of glasgow district council and shoprite limited dated 22 september and 3 october 1984 and now registered in the land register of scotland under title number GLA110299 of premises comprising 1.6 hectares at cathcart road, glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 17. Dez. 1997 Geliefert am 22. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0