FLEETS POINT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFLEETS POINT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03075946
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FLEETS POINT LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich FLEETS POINT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    BARRY BROOMBERG OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLP
    Fleet Point Verde 10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FLEETS POINT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FITNESS FIRST LIMITED18. Aug. 200318. Aug. 2003
    FITNESS FIRST PLC23. Sept. 199623. Sept. 1996
    FITNESS FIRST GROUP LIMITED29. Juni 199529. Juni 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEETS POINT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für FLEETS POINT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Barry Alan Broomberg als Geschäftsführer am 31. Mai 2023

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2022

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2021

    6 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2020

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019

    6 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Änderung der Details des Direktors für Mr Barry Alan Broomberg am 18. Nov. 2019

    3 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Verde Bressenden Place London SW1E 5DH England zum Fleet Point 10 Bressenden Place London SW1E 5DH am 17. Dez. 2019

    2 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen

    2 SeitenCS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Paul Richard Stevens als Geschäftsführer am 20. Sept. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2018

    34 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Susan Anne Cadd als Sekretär am 05. Sept. 2018

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 52 Willis Way Poole BH15 3SY England zum Verde Bressenden Place London SW1E 5DH am 04. Sept. 2018

    1 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cash dividend of £3166632.46 paid 26/06/2018
    RES13

    Erfüllung der Belastung 030759460023 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 030759460024 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2017

    44 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FLEETS POINT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BALFOUR, Michael William
    1belvedere House 6 Mckinley Road
    BH4 8AQ Bournemouth
    Dorset
    Sekretär
    1belvedere House 6 Mckinley Road
    BH4 8AQ Bournemouth
    Dorset
    British36866470002
    CADD, Susan Anne
    Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Verde
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Verde
    England
    British82401780001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BALFOUR, Michael William
    11 Bury Road
    BH13 7DD Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    11 Bury Road
    BH13 7DD Poole
    Dorset
    British36866470005
    BAMFORD, Stephen James
    Glengarden Farmleigh Grove
    Burwood Park
    KT12 5BU Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Glengarden Farmleigh Grove
    Burwood Park
    KT12 5BU Walton On Thames
    Surrey
    British47964750001
    BICKLE, Justin Andrew
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    United Kingdom
    EnglandBritish112506210002
    BODDY, Peter Ashley
    The Old Rectory
    Church Hill Road
    LE16 7SN Cranoe
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Church Hill Road
    LE16 7SN Cranoe
    Leicestershire
    EnglandBritish101072960001
    BROOMBERG, Barry Alan
    Fleet Point
    Verde 10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Oaktree Capital Management Llp
    England
    Geschäftsführer
    Fleet Point
    Verde 10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Oaktree Capital Management Llp
    England
    United KingdomBritish207557180001
    BYNG MADDICK, Zillah
    Russet House
    14 Claremont Gardens
    SL7 1BS Slough
    Geschäftsführer
    Russet House
    14 Claremont Gardens
    SL7 1BS Slough
    EnglandBritish118619550001
    CARTWRIGHT, Nigel Ronald
    Staithe The Causeway
    KT10 0NE Claygate
    Surrey
    Geschäftsführer
    Staithe The Causeway
    KT10 0NE Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish51888080001
    CHESTER, Ross
    Compass Court
    42/44 Winn Road
    SO17 1EQ Southampton
    Geschäftsführer
    Compass Court
    42/44 Winn Road
    SO17 1EQ Southampton
    British121959520001
    CHILD, Colin Charles
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    Geschäftsführer
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    EnglandBritish125146440001
    DENNING, Edward John
    Lowder Mill
    Bell Vale Lane
    GU27 3DJ Haselmere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Lowder Mill
    Bell Vale Lane
    GU27 3DJ Haselmere
    Surrey
    United KingdomBritish5755650002
    ENOCH, Melvyn Stuart
    9 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    9 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    British57420500001
    FEINGOLD, Limor
    23 Elms Avenue
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    23 Elms Avenue
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    British109022770001
    FEINGOLD, Limor
    4 Moriconium Quay
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    4 Moriconium Quay
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British99858900001
    GOLDSMITH, Walter Kenneth
    21 Ashurst Close
    HA6 1EL Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    21 Ashurst Close
    HA6 1EL Northwood
    Middlesex
    British10845240002
    GUSCOTT, Malcolm Sinclair
    6 Mckinley Road
    BH4 8AQ Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    6 Mckinley Road
    BH4 8AQ Bournemouth
    Dorset
    British47529000005
    KENGELBACH, Jan
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Geschäftsführer
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandGerman166791090001
    LIGHT, Craig Jonathan
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Geschäftsführer
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandBritish175309730001
    MCGOLDRICK, James Edward
    Morfelderlandstr 265
    FOREIGN Frankfurt
    60598
    Germany
    Geschäftsführer
    Morfelderlandstr 265
    FOREIGN Frankfurt
    60598
    Germany
    American86450530001
    METCALF, Michael Edward
    Tanglewood 19 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Tanglewood 19 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    EnglandBritish61013220001
    NEWMAN, Timothy Carlo
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Geschäftsführer
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandBritish133499820001
    NEWMAN, Timothy Carlo
    Charlton Marshall
    DT11 9NE Blandford
    Newlands Manor House
    Dorset
    Geschäftsführer
    Charlton Marshall
    DT11 9NE Blandford
    Newlands Manor House
    Dorset
    EnglandBritish133499820001
    PEARCE, Christopher Donovan James
    Pembridge House
    Pachesham Park
    KT22 0DJ Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pembridge House
    Pachesham Park
    KT22 0DJ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish20666800004
    PHILLIPS, Sean
    39 Western Avenue
    Branscote Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    39 Western Avenue
    Branscote Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    American44839890004
    STEVENS, Paul Richard
    Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Verde
    England
    Geschäftsführer
    Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Verde
    England
    EnglandBritish186050040001
    TATTON-BROWN, Duncan Eden
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Geschäftsführer
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandBritish149245720001
    WAGGETT, Colin Douglas
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Geschäftsführer
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandBritish104154090003
    WARTIG, John Michael
    Willis Way
    BH15 3SY Poole
    52
    England
    Geschäftsführer
    Willis Way
    BH15 3SY Poole
    52
    England
    EnglandAustralian178768810001
    WILLIAMS, Jeremy David
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Geschäftsführer
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    United KingdomBritish121982220002
    WILLIAMS, Jeremy David
    Witchampton
    BH21 5AR Wimborne
    Welcombe Thatch
    Geschäftsführer
    Witchampton
    BH21 5AR Wimborne
    Welcombe Thatch
    United KingdomBritish121982220002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FLEETS POINT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Moraylimited
    Fleets Lane
    BH15 3BT Poole
    58
    England
    06. Apr. 2016
    Fleets Lane
    BH15 3BT Poole
    58
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngalnd And Wales
    Registrierungsnummer4698751
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat FLEETS POINT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 25. Apr. 2014
    Geliefert am 06. Mai 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 06. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 25. Okt. 2016Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 15. Aug. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 25. Apr. 2014
    Geliefert am 06. Mai 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 06. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Dez. 2015Teilweise Erfüllung einer Belastung (MR04)
    • 15. Aug. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Sept. 2013
    Geliefert am 17. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited (and Its Successors in Title, Pemitted Assigns and Permitted Transferees)
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 26. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Sept. 2013
    Geliefert am 17. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Trademark id: 36447 country UK reg no 2111128, 43481 country european union reg no 898734, 43481AT country austria reg no 898734, for details of further trademarks please refer to the document image. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited (and Its Successors in Title, Permitted Assigns and Permitted Transferees)
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 26. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge of deposit
    Erstellt am 01. Aug. 2012
    Geliefert am 07. Aug. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All amounts now and in the future credited to account numbers 550/00/31194249 and 28424301 with the bank.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation and amendment agreement
    Erstellt am 14. Dez. 2010
    Geliefert am 23. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Th shares being the two shares in the amount of eur 25,000.00 and eur 2,475,000.00 together with all ancillary rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corparate Bank, LTD (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Pledge agreement
    Erstellt am 14. März 2008
    Geliefert am 26. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first ranking pledge over the shares and all future shares see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD ( as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 26. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An agreement and deed of pledge of shares
    Erstellt am 17. Aug. 2007
    Geliefert am 01. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge agreement
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 13. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charging company pledged to the pledgees all of its shares in the company being the share capital held by the charging company of one share of dem 636,000.00 and the share capital of dem 9,964,000.00 held by pledgor 2 consisting of 9 shares in the nominal amount of dem 62,500.00, dem 12,500.00, dem 905,000.00, dem 12,500.00, dem 37,500.00, dem 770,000.00, dem 990,000.00, dem 520,000.00 and dem 6,654,000.00 (together with any future shares of the pledgors) and all present and future rights attached to the shares.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD as Security Agent for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Agreement and deed of pledge of shares
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Five thousand issued and outstanding shares numbered 1 up to and including 5000 each with a nominal capital of one hundred euro (eur 100) in the share capital of the company and registered in the name of the charging company and all dividends and distributions in respect of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (In Its Capacity as Security Agent for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge agreement
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 13. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charging company pledged to the pledgee all of its shares in the company being the share capital of eur 2,500,000.00 of the company consisting of two shares in the amount of eur 25,000.00 and eur 2,475,000.00 held by the charging company (together with any future shares of the charging company after the charge date) and all present and future rights attached to the shares.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD as Security Agent for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 30. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in respect of sums payable pursuant to the insurance policies all rights title and interest in respect of the hedging agreements and all rights title and interest in resp. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 01. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares the additional rights and the designated account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share charge
    Erstellt am 30. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1,895,316 shares of hk$1 each in the issued share capital of the company and the derivative assets owned by the charging company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 30. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The 18,128,482 registered shares in the company owned by the charging company from the pledge date any and all rights to aquire shares in the capital of the company which rights the charging company has at the pledge date and any and all other rights pertaining to the shares from the pledge date including the right to receive all interest and dividend rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 09. Okt. 2003
    Geliefert am 21. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Legal mortgage all the land fixed charge all ,plant and machinery, rental and other income, investments, rights under insurances, goodwill and uncalled capital, intellectual property, agreements and licences, trade secrets, confidential information and know-how, rights and causes of action in respect of infringements, book and other debts, claims against third parties, negotiable instruments, claims in any pension fund, monies standing to any realisation account, rights over land, floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 25TH july 2003 and
    Erstellt am 24. Juni 2003
    Geliefert am 08. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each and any chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the l/h interest in the east side of cathcart road glasgow t/n GLA110299.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share mortgage
    Erstellt am 24. Juni 2003
    Geliefert am 08. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future shares and new rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 08. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share charge
    Erstellt am 24. Juni 2003
    Geliefert am 08. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 08. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and supplemental charge supplemental to a debenture dated 10 april 2003 and
    Erstellt am 24. Juni 2003
    Geliefert am 04. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 04. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share pledge agreement
    Erstellt am 23. Juni 2003
    Geliefert am 14. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent, the company and or all other obligors to the pledgee and/or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All shares of the pledging company including all present and future rights attached to the shares.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 21. Juni 1999
    Geliefert am 08. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the financing documents including the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 291298
    Erstellt am 01. Dez. 1998
    Geliefert am 07. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The tenant's interest under the lease between the city of glasgow district council and shoprite limited dated 22 september and 3 october 1984 and now registered in the land register of scotland under title number GLA110299 of premises comprising 1.6 hectares at cathcart road, glasgow.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 17. Dez. 1997
    Geliefert am 22. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0