OAKGATE PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OAKGATE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03077617 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OAKGATE PROPERTIES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich OAKGATE PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Castlegarth Grange Scott Lane LS22 6LH Wetherby England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OAKGATE PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LANDCLASS LIMITED | 10. Juli 1995 | 10. Juli 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OAKGATE PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OAKGATE PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Oakgate House 25 Market Place Wetherby West Yorkshire LS22 6LQ zum Castlegarth Grange Scott Lane Wetherby LS22 6LH am 12. Mai 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 31. Aug. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John David Grantham als Geschäftsführer am 16. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John David Grantham am 01. Jan. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Edward France am 01. Jan. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Caddick am 01. Jan. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Andrew Bullers als Sekretär am 20. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Graham Hirst als Geschäftsführer am 20. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Andrew Bullers als Direktor am 20. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Graham Hirst als Sekretär am 20. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OAKGATE PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLERS, Paul Andrew | Sekretär | Scott Lane LS22 6LH Wetherby Castlegarth Grange England | 194298910001 | |||||||
| BULLERS, Paul Andrew | Geschäftsführer | Scott Lane LS22 6LH Wetherby Castlegarth Grange England | England | British | 155801480001 | |||||
| CADDICK, Paul | Geschäftsführer | Scott Lane LS22 6LH Wetherby Castlegarth Grange England | United Kingdom | British | 2288420001 | |||||
| FRANCE, Richard Edward | Geschäftsführer | Scott Lane LS22 6LH Wetherby Castlegarth Grange England | United Kingdom | British | 56208840002 | |||||
| HIRST, Peter Graham | Sekretär | The Coach House Outwood Lane Horsforth LS18 4HR Leeds West Yorkshire | British | 32603370002 | ||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003220001 | |||||||
| GRANTHAM, John David | Geschäftsführer | Oakgate House 25 Market Place LS22 6LQ Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | 48928850002 | |||||
| HIRST, Peter Graham | Geschäftsführer | The Coach House Outwood Lane Horsforth LS18 4HR Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 32603370002 | |||||
| LUCIENE JAMES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OAKGATE PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddick Group Plc | 06. Apr. 2016 | Scott Lane LS22 6LH Wetherby Castlegarth Grange West Yorkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Oakgate Group Plc | 06. Apr. 2016 | Market Place LS22 6LQ Wetherby Oakgate House West Yorkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat OAKGATE PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Erstellt am 08. Juli 1999 Geliefert am 21. Juli 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 19 december 1997 | |
Kurze Angaben 7 blake street york together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 18. Jan. 1999 Geliefert am 29. Jan. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 19TH december 1997 | |
Kurze Angaben Stonegate walk stonegate york-NYK11567 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 23. Dez. 1998 Geliefert am 09. Jan. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein ("group member") to the chargees on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies from time to time due or owing or incured to the company under the occupational leases in respect of 26,28 and 30 stonegate york t/no's;-NYK29311. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 23. Dez. 1998 Geliefert am 09. Jan. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any group member to the chargees supplemental to the legal charge dated 19TH december 1997 between oakgate group PLC and norwich union mortgage finance limited | |
Kurze Angaben 26,28 and 30 stonegate york t/no;-NYK29311 together with all buildings fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) fixed plant and machinery all improvements and additions thereto benefits under all leases and licences in relation to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed of charge | Erstellt am 13. Mai 1998 Geliefert am 22. Mai 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge which is supplemental to the principal deed dated 19TH december 1997 | |
Kurze Angaben F/H property k/a units e,f and g 25/27 market place wetherby west yorkshire together with all buildings erections and fixtures (including trade but excluding tenant's fixtures) fixed plant machinery all improvements and additions thereto all rights and licences benefits of all leases underleases tenancies agreements to lease covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance and floating charge the whole of the company's undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of cash deposit | Erstellt am 19. Nov. 1996 Geliefert am 05. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Initial deposit of £280,000 credited to acct/no 00219229 with the bank and any addition to that deposit in any currency. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 15. Okt. 1996 Geliefert am 23. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The amount from time to time standing to the credit of account number 00219210 with the bank and any deposit from time to time of the company with the bank of any other currency description designation or numbering etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of cash deposit | Erstellt am 15. Okt. 1996 Geliefert am 23. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The amount from time to time standing to the credit of account number 00219237 with the bank and any deposit from time to time of the company with the bank of any other currency description designation or numbering etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Okt. 1996 Geliefert am 23. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Okt. 1996 Geliefert am 23. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 7 - 11 trinity street (formerly k/a the ostlers arms) leeds t/no wyk 521321 with the goodwill of the business and proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0