HAMMOND BRIDGE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HAMMOND BRIDGE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03082707 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAMMOND BRIDGE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HAMMOND BRIDGE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 142b Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon Oxon England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HAMMOND BRIDGE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PROUDLOCAL LIMITED | 21. Juli 1995 | 21. Juli 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAMMOND BRIDGE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAMMOND BRIDGE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2020 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Dez. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Monique Louis als Geschäftsführer am 01. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Monique Louis als Direktor am 01. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 140 Eastern Avenue Milton Park, Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4SB England zum 142B Park Drive Milton Park Abingdon Oxon OX14 4SE am 04. Okt. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Jozsef Lagler als Direktor am 01. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gregory Davidson-Shrine als Geschäftsführer am 01. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gregory Davidson-Shrine als Sekretär am 01. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Sept. 2019
| 14 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wilson als Geschäftsführer am 31. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Crookes als Geschäftsführer am 30. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Lewendon als Geschäftsführer am 12. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Adrian Crookes als Direktor am 12. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HAMMOND BRIDGE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGLER, Mark Jozsef | Geschäftsführer | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | United Kingdom | British | 227904200001 | |||||
| MARTIN, Neil Thomas George | Geschäftsführer | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | United Kingdom | British | 126681070006 | |||||
| DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Sekretär | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | 234770870001 | |||||||
| ELSEY, Robert David | Sekretär | 7 Ravenscroft Gardens BA14 7JU Trowbridge Wiltshire | British | 44433580001 | ||||||
| GAHAN, Michael William | Sekretär | The Orchard Vinegar Hill NP26 3EJ Undy Gwent | British | 182707860001 | ||||||
| JARRETT, Susan Lynne | Sekretär | 37 Bobbin Lane Westwood BA15 2DL Bradford On Avon Wiltshire | British | 54448350001 | ||||||
| MARRINER, Stuart Steven | Sekretär | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | 168621380001 | |||||||
| STAFFORD, Robert Simeon | Sekretär | 4 Clifton Wood Crescent Clifton Wood BS8 4TU Bristol | British | 77214360002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARNETT, Mark William | Geschäftsführer | Old Meadows Farm Fowlswick Lane, Allington SN14 6LT Chippenham Wiltshire | England | British | 78407520002 | |||||
| BAUERNFEIND, David Gregory | Geschäftsführer | Cherry Orchard North Kembrey Park SN2 8UH Swindon Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | 99529910002 | |||||
| BUNTING, Jonathan Michael | Geschäftsführer | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | 115232260002 | |||||
| CADDELL, Joseph | Geschäftsführer | Pipers Way SN3 1RF Swindon Wakefield House Wiltshire United Kingdom | England | British | 115479170002 | |||||
| CASHMORE, Mark Richard | Geschäftsführer | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | 115657470004 | |||||
| COOK, Kevin Nigel | Geschäftsführer | 4 Sandcroft Avenue BS23 4SS Weston Super Mare North Somerset | British | 86627710001 | ||||||
| CROOKES, Adrian | Geschäftsführer | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | 174571650001 | |||||
| DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Geschäftsführer | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | 169072790002 | |||||
| DIBBEN, Kenneth Francis | Geschäftsführer | Naish Priory East Coker BA22 9HQ Yeovil Somerset | British | 14097180001 | ||||||
| DIXON, Nigel Anthony | Geschäftsführer | Manor Farm House SP4 0JZ Porton Wiltshire | England | British | 92047990001 | |||||
| ELSEY, Robert David | Geschäftsführer | 7 Ravenscroft Gardens BA14 7JU Trowbridge Wiltshire | United Kingdom | British | 44433580001 | |||||
| ELSEY, Robert David | Geschäftsführer | 7 Ravenscroft Gardens BA14 7JU Trowbridge Wiltshire | United Kingdom | British | 44433580001 | |||||
| GAHAN, Michael William | Geschäftsführer | The Orchard Vinegar Hill NP26 3EJ Undy Gwent | United Kingdom | British | 182707860001 | |||||
| GAYLER, David Richard | Geschäftsführer | Grey Gables GL7 4HD Kempsford Gloucestershire | British | 4759540001 | ||||||
| GEORGE, Dudley Robert Charles | Geschäftsführer | School Cottage Coaley GL11 5ED Dursley Gloucestershire | British | 44433600001 | ||||||
| GEORGE, Dudley Robert Charles | Geschäftsführer | School Cottage Coaley GL11 5ED Dursley Gloucestershire | British | 44433600001 | ||||||
| GOULD, Jeffrey Richard | Geschäftsführer | 4 Hobbs Hill Keevil BA14 6LR Trowbridge Wiltshire | British | 45469620001 | ||||||
| GRESHAM, Nicholas John | Geschäftsführer | Cherry Orchard North Kembrey Park SN2 8UH Swindon Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | 91773790002 | |||||
| JARRETT, Susan Lynne | Geschäftsführer | 37 Bobbin Lane Westwood BA15 2DL Bradford On Avon Wiltshire | British | 54448350001 | ||||||
| KERSHAW, John Graham Christopher | Geschäftsführer | Pipers Way SN3 1RF Swindon Wakefield House Wiltshire United Kingdom | England | British | 165578560001 | |||||
| LAMMING, Richard, Professor | Geschäftsführer | 26 Bath Road Beckington BA11 6SL Frome | United Kingdom | British | 46380760002 | |||||
| LEECH, Glenn Peter | Geschäftsführer | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | 131999190002 | |||||
| LEWENDON, Craig Stuart | Geschäftsführer | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | 234768920001 | |||||
| LOUIS, Monique | Geschäftsführer | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 238289490001 | |||||
| PALMER, Matthew James | Geschäftsführer | Pipers Way SN3 1RF Swindon Wakefield House Wiltshire United Kingdom | England | British | 149814290001 | |||||
| POTTER, Brian Geoffrey | Geschäftsführer | Cote Bank 65a Bristol Road Lower BS23 2TL Weston Super Mare Somerset | British | 72749380002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HAMMOND BRIDGE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedgelane Limited | 06. Apr. 2016 | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HAMMOND BRIDGE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 03. Dez. 2004 Geliefert am 16. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the south west side of hammond way trowbridge t/n WT85869. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Nov. 2004 Geliefert am 16. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Mai 2002 Geliefert am 28. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Aug. 1998 Geliefert am 28. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land/blds on south west side of hammond way trowbridge wiltshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Nov. 1995 Geliefert am 09. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Nov. 1995 Geliefert am 07. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0