THE IGRANIC GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | THE IGRANIC GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03083310 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE IGRANIC GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich THE IGRANIC GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Compass Point Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames Middlesex England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE IGRANIC GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
THE IGRANIC GROUP P.L.C. | 24. Nov. 1997 | 24. Nov. 1997 |
IGRANIC (1995) LIMITED | 03. Aug. 1995 | 03. Aug. 1995 |
LINENOBLE LIMITED | 24. Juli 1995 | 24. Juli 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE IGRANIC GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE IGRANIC GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Okt. 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Stephen Wilkes als Geschäftsführer am 14. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Cecil Blythe als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Iain Angus Jones als Sekretär am 18. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Muirhead Birnie Brown als Sekretär am 18. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 31 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Ernennung von Robert Muirhead Birnie Brown als Sekretär am 21. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Lesley John Hinder am 21. Sept. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Gary Wilkes als Direktor am 21. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andy Seabrook als Geschäftsführer am 21. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Cecil Blythe als Direktor am 21. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Lesley John Hinder als Direktor am 21. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Michael Whitbread als Geschäftsführer am 21. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE IGRANIC GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Iain Angus | Sekretär | Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames Compass Point Middlesex England | 203968830001 | |||||||
HINDER, Leslie John | Geschäftsführer | Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames Compass Point Middlesex England | United Kingdom | British | Director | 3290930002 | ||||
BRICE, Ian Malcolm | Sekretär | 10 Brook Street MK42 0QR Bedford Bedfordshire | British | Company Director | 21396080001 | |||||
BROWN, Robert Muirhead Birnie | Sekretär | Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames Compass Point Middlesex England | 201551540001 | |||||||
HOLMES, Kirstie Sian | Sekretär | 1 Spencer Road Long Buckby NN6 7YP Northamptonshire | British | 79008020001 | ||||||
HOOK, Robert Neil | Sekretär | Igranic Works 50 Murdock Road MK41 7PT Bedford Bedfordshire | 154553150001 | |||||||
KITCHING, Lyn Paula | Sekretär | 17 The Green Marston Moretaine MK43 0NF Bedford | British | 55679350002 | ||||||
LARKIN, Thomas | Sekretär | 5 Clayland Close Bozeat NN29 7NT Wellingborough Northamptonshire | British | 90913450001 | ||||||
MARRIOTT, Lynn | Sekretär | 30 Badgers Oak Kents Hill MK7 6HS Milton Keynes Buckinghamshire | British | 86025700001 | ||||||
NEWELL, Dean Frazer | Sekretär | Wrest Park Silsoe MK45 4HS Bedford Autotech Controls United Kingdom | 171501560001 | |||||||
SEABROOK, Andy | Sekretär | Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames Compass Point Middlesex England | 181217280001 | |||||||
SEABROOK, Andy | Sekretär | 202 Stewartby Way Stewartby MK43 9LN Bedford Bedfordshire | British | Accountant | 100439280001 | |||||
SECRETAIRE LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 3rd Floor 2 Luke Street EC2A 4NT London | 900011490001 | |||||||
BLYTHE, John Cecil | Geschäftsführer | Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames Compass Point Middlesex England | United Kingdom | British | Director | 176859610001 | ||||
BRICE, Ian Malcolm | Geschäftsführer | 10 Brook Street MK42 0QR Bedford Bedfordshire | England | British | Company Director | 21396080001 | ||||
BROWN, Kevin Thomas | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 30 Harts Grove IG8 0BN Woodford Green Essex | England | British | 900008020001 | |||||
COLE, Thomas William | Geschäftsführer | Mayfield Cottage Lodge Green Burton Park GU28 0LH Duncton West Sussex | England | British | Business Adviser | 126834600001 | ||||
FENN, Mark | Geschäftsführer | London Road AL1 1NS St. Albans 72 Hertfordshire | United Kingdom | British | None | 168504190001 | ||||
LEE, Christopher | Geschäftsführer | 5 New Road Bromham MK43 8QH Bedford | British | Director | 21396090002 | |||||
NUNN, David George | Geschäftsführer | 5 Cheltenham Close Putnoe MK41 8RL Bedford Bedfordshire | England | British | Company Director | 21396040001 | ||||
ROBINSON, Andrew | Geschäftsführer | The Oaks Silsoe MK45 4EL Bedford 6 Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 48633190002 | ||||
SEABROOK, Andy | Geschäftsführer | Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames Compass Point Middlesex England | United Kingdom | British | Accountant | 161331390001 | ||||
STANTON, Anthony Howard | Geschäftsführer | Filleigh Mews Chudleigh TQ13 0DE Newton Abbot Devon | England | British | Engineer | 159202070001 | ||||
WARE, John Lewis, Mr. | Geschäftsführer | 9 Egglestone Close Kempston MK42 8QE Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 21396050001 | ||||
WHITBREAD, Peter Michael | Geschäftsführer | 7 Ramillies Close Kempston MK42 8SP Bedford Beds | England | British | Director | 21396060001 | ||||
WILDMAN, Glyn William | Geschäftsführer | 32 Chantry Road Kempston MK42 7QU Bedford Bedfordshire | British | Director | 21396070001 | |||||
WILKES, Gary Stephen | Geschäftsführer | Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames Compass Point Middlesex England | England | British | Director | 176859480001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE IGRANIC GROUP LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automated Technology Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Kingston Road TW18 1DT Staines-Upon-Thames 79-87 Middlesex England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat THE IGRANIC GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 12. Apr. 2012 Geliefert am 18. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. März 2001 Geliefert am 30. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. März 2001 Geliefert am 30. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. März 2001 Geliefert am 30. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. März 2001 Geliefert am 30. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. März 2001 Geliefert am 30. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 21. Sept. 1995 Geliefert am 05. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0