FIFEDALE TRADING LTD.
Überblick
| Unternehmensname | FIFEDALE TRADING LTD. |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03084590 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIFEDALE TRADING LTD.?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FIFEDALE TRADING LTD.?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Canal Mill Botany Bay Villages Botany Brow PR6 8AX Chorley Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FIFEDALE TRADING LTD.?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BOTANY BAY TRADING COMPANY LIMITED | 27. Juli 1995 | 27. Juli 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIFEDALE TRADING LTD.?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIFEDALE TRADING LTD.?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2023 bis 30. Jan. 2023 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2022 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2021 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2020 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2019 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2018 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2017 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FIFEDALE TRADING LTD.?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARP, Claire Caroline | Sekretär | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | British | 141979130001 | ||||||
| HOPKINSON, Thomas Duncan | Geschäftsführer | Bank House Sawley Road Sawley BB7 4RS Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | 71862660002 | |||||
| KNOWLES, Timothy John Peter | Geschäftsführer | Canal Mill Botany Bay Villages Botany Brow PR6 8AX Chorley Lancashire | Isle Of Man | British | 33274370003 | |||||
| SHARP, Claire Caroline | Geschäftsführer | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | England | British | 141979130001 | |||||
| ALLEN, Rachel Mary | Sekretär | 1263 Burnley Road Loveclough BB4 8RG Rossendale Lancashire | British | 98369110001 | ||||||
| JENKINSON, Jayne Elizabeth | Sekretär | Inglemere Langley Lane, Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | British | 85366800001 | ||||||
| MCMILLAN, Alan John | Sekretär | 5 Stocks Court Heskin PR7 5JN Chorley Lancashire | British | 117341260001 | ||||||
| SHARP, Claire Caroline | Sekretär | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | British | 141979130001 | ||||||
| SHARP, Claire Caroline | Sekretär | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | British | 141979130001 | ||||||
| WESTHEAD, Paul | Sekretär | 11 Delph Way Whittle Le Woods PR6 7TG Chorley Lancashire | British | 72955010002 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| DIXON, William Ronald | Geschäftsführer | Cumberland Drive WA14 3QP Bowdon 27 Cheshire | England | British | 136501510001 | |||||
| JENKINSON, Jayne Elizabeth | Geschäftsführer | Inglemere Langley Lane, Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | England | British | 85366800001 | |||||
| KNOWLES, Timothy John Peter | Geschäftsführer | Clogh Willey Cottage Tosaby Road Stoney Mountain IM9 3AN St Marks Isle Of Man | Isle Of Man | British | 33274370003 | |||||
| KRELL, Terry Malcolm | Geschäftsführer | 84 Palatine Road Withington M20 3LW Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 105128110001 | |||||
| RIGBY, John James | Geschäftsführer | Blackburnhouse Farm Tannersmith Lane Mawdsley PR7 5PD Chorley Lancs | United Kingdom | British | 33274380001 | |||||
| SHARP, Claire Caroline | Geschäftsführer | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | England | British | 141979130001 | |||||
| WOOD, Gerald Jospeh | Geschäftsführer | 1 Stanley Road Farington PR25 4RH Leyland Lancashire | England | British | 110948700001 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FIFEDALE TRADING LTD.?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britannic Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Botany Brow PR6 9AF Chorley Canal Mill Lancashire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FIFEDALE TRADING LTD. Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 29. Juli 2008 Geliefert am 02. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 194 spendmore lane coppull chorley t/n LA656981 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Juli 2008 Geliefert am 02. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of longmeanygate leyland t/n LA651986 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Juli 2008 Geliefert am 02. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 86 and 101 anderton street chorley t/nos LA643162 LA551456 LA608532 and LA651102 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Juli 2008 Geliefert am 02. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 224 leyland lane, leyland t/n LA542853 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juli 2002 Geliefert am 23. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any transferee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Bank account charge | Erstellt am 08. Juli 2002 Geliefert am 19. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its rights title and interest in and to each of the accounts and the deposits and all and any right to the repayment of all or any part thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Nov. 1996 Geliefert am 30. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0