STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03086914 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | L5 19 High Flatworth Tyne Tunnel Trading Estate NE29 7UT North Shields Tyne & Wear England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Erfüllung der Belastung 030869140004 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||
Erfüllung der Belastung 030869140003 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Murray Mckay Kerr als Geschäftsführer am 11. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 24 Seiten | AA | ||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 2 Stargate Business Park Stargate, Ryton Gateshead Tyne & Wear NE40 3EX zum L5 19 High Flatworth Tyne Tunnel Trading Estate North Shields Tyne & Wear NE29 7UT am 18. Sept. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Ernennung von Ms Kerrie Rae Doreen Murray als Direktor am 14. Mai 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Ernennung von Mr Murray Mckay Kerr als Direktor am 01. Mai 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Ernennung von Ms Kerrie Rae Doreen Murray als Sekretär am 14. Mai 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Frank William Watson als Geschäftsführer am 14. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Frank William Watson als Sekretär am 14. Mai 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 24 Seiten | AA | ||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Angus John Gray am 11. Nov. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Eintragung der Belastung 030869140004, erstellt am 29. Juni 2017 | 36 Seiten | MR01 | ||||||
Zweite Einreichung für die Abberufung von Martin Wright als Geschäftsführer | 5 Seiten | RP04TM01 | ||||||
Ernennung von Mr Angus John Gray als Direktor am 27. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Paul Wright als Geschäftsführer am 31. Jan. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||
| ||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Aitken als Geschäftsführer am 19. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 24 Seiten | AA | ||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY, Kerrie Rae Doreen | Sekretär | 19 High Flatworth Tyne Tunnel Trading Estate NE29 7UT North Shields L5 Tyne & Wear England | 246543360001 | |||||||
| GRAY, Angus John | Geschäftsführer | 19 High Flatworth Tyne Tunnel Trading Estate NE29 7UT North Shields L5 Tyne & Wear England | United Kingdom | British | 229846740002 | |||||
| MURRAY, Kerrie Rae Doreen | Geschäftsführer | 19 High Flatworth Tyne Tunnel Trading Estate NE29 7UT North Shields L5 Tyne & Wear England | United Kingdom | British | 190064610001 | |||||
| TREEN, John | Sekretär | 12 Briar Terrace Burnopfield NE16 6DX Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 5164630001 | ||||||
| WATSON, Frank William | Sekretär | Tom Johnston Road West Pitkerro Industrial Estate DD4 8XD Dundee 11 Tayside Scotland | 201520560001 | |||||||
| WRIGHT, Louise | Sekretär | Stargate Business Park Stargate, Ryton NE40 3EX Gateshead Unit 2 Tyne & Wear | 168397140001 | |||||||
| DMCS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900006030001 | |||||||
| AITKEN, Gavin | Geschäftsführer | Tom Johnston Road West Pitkerro Industrial Estate DD4 8XD Dundee 11 Scotland | Scotland | British | 201729970001 | |||||
| FENWICK, Stewart | Geschäftsführer | 4 Delhi Gardens Woodside NE40 4QS Ryton Tyne & Wear | British | 54159860001 | ||||||
| KERR, Murray Mckay | Geschäftsführer | 19 High Flatworth Tyne Tunnel Trading Estate NE29 7UT North Shields L5 Tyne & Wear England | United Kingdom | British | 119192990002 | |||||
| NASSOR, Rahmon Seif | Geschäftsführer | Stargate Business Park Stargate, Ryton NE40 3EX Gateshead Unit 2 Tyne & Wear | United Kingdom | British | 44306500005 | |||||
| TREEN, John | Geschäftsführer | 12 Briar Terrace Burnopfield NE16 6DX Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 5164630001 | |||||
| WATSON, Frank William | Geschäftsführer | Tom Johnston Road West Pitkerro Industrial Estate DD4 8XD Dundee 11 Tayside Scotland | Scotland | British | 196241300001 | |||||
| WRIGHT, Martin Paul | Geschäftsführer | Stargate Business Park Stargate, Ryton NE40 3EX Gateshead Unit 2 Tyne & Wear | United Kingdom | British | 30576300003 | |||||
| WRIGHT, Michael Keith | Geschäftsführer | Stargate Business Park Stargate, Ryton NE40 3EX Gateshead Unit 2 Tyne & Wear | England | British | 4561130002 | |||||
| DMCS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900004430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pryme Group Ltd | 02. Aug. 2016 | Tom Johnston Road West Pitkerro Ind Estate DD4 8XD Dundee 11 Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat STARGATE PRECISION ENGINEERING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 29. Juni 2017 Geliefert am 04. Juli 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 3.1 each chargor, as continuing security for the payment, discharge and performance of all the secured obligations in relation to all of the following assets whether now or in future belonging to it hereby, in each case with full title guarantee:. (A) fixed charges: charges to igf by way of separate fixed charges:. (I) by way of legal mortgage each property specified in schedule 2;. (ii) by way of equitable mortgage its real property, other than the property or properties specified in schedule 2;. (vi) all its intellectual property;. Intellectual property means in relation to any of the chargors, all patents (including applications for and rights to apply for patents), trade marks and service marks (whether registered or not) and applications for the same, trade names, registered designs, design rights, semi-conductor topography rights, database rights, copyrights, computer programs, know-how and trade secrets and all other intellectual or intangible property or rights and all licences, agreements and ancillary and connected rights relating to intellectual and intangible property including any renewals, revivals or extensions thereof and wherever in the world subsisting.. Real property means, to the extent situated in england or wales, all freehold and leasehold properties and other real property both present and future (including the property or properties specified in schedule 2 and set opposite its name) of any of the chargors, including all buildings and other structures from time to time erected thereon and all fixtures (trade or otherwise) from time to time thereon or therein.. Secured obligations means all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly or severally, as principal or as surety or in any capacity whatsoever) of each of the obligors to igf on any account whatsoever and howsoever arising (including, without limitation, under the finance documents) together with all expenses. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 11. Sept. 2015 Geliefert am 23. Sept. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 06. Nov. 2003 Geliefert am 12. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 31. Okt. 1995 Geliefert am 13. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0