APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED

APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAPTA HEALTHCARE (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03088888
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HAVENGREEN HEALTH LIMITED08. Aug. 199508. Aug. 1995

    Welche sind die letzten Einreichungen für APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 18. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    25 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    25 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    British40240710001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Sekretär
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Sekretär
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Sekretär
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Sekretär
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304580001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Sekretär
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Geschäftsführer
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    British40240710001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Geschäftsführer
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish124228290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEARN, Lynn
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    United KingdomBritish130867640001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Geschäftsführer
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Geschäftsführer
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    FOULKES, Kamma
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    United KingdomBritish111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Geschäftsführer
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritish93592160001
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Geschäftsführer
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    GWATKIN, Peter Frederick Stapleton
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    Geschäftsführer
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    British42082340004
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Geschäftsführer
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    HEAPS, Ann
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    British124068050001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Geschäftsführer
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Geschäftsführer
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001

    Hat APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental debenture
    Erstellt am 28. Okt. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title estate and other interest in land adjoining willow court nursing home croft lane cherry willingham lincolnshire.
    Berechtigte Personen
    • Care Homes No. 1 Limited
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Okt. 2005
    Geliefert am 04. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Initial deposit, all interest, the deposit account, and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 2 Limited
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Okt. 1999
    Geliefert am 16. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on l/h premises at millfield care centre, bury new road heywood OL10 4RF.together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery the goodwill its uncalled capital and book and other debts.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security dated 9TH july 1999 and presented for registration in scotland on 28TH july 1999
    Erstellt am 28. Juli 1999
    Geliefert am 30. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5,207 acres to the north west of murrayfield avenue edinburgh & 5,207 acres to the west of succoth avenue edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No 3 Limited
    Transaktionen
    • 30. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security dated 9TH july 1999 and presented for registration in scotland on 27TH july 1999
    Erstellt am 27. Juli 1999
    Geliefert am 30. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Annfield house annfield gardens stirling t/n stg 9911.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No 3 Limited
    Transaktionen
    • 30. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 13. Juli 1999
    Geliefert am 17. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 23RD april 1999
    Kurze Angaben
    The tenant charges 1. the initial deposit 2. all interest 3. the deposit account, and 4 the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 17. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 13. Juli 1999
    Geliefert am 17. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 23RD april 1999
    Kurze Angaben
    The tenant charge 1. initial deposit 2. all interest 3. the deposit account, and 4. the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 17. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 13. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a newton court care centre st anne's road middlewitch. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 13. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a grosvenor house 38 duchey road harrogate. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 28. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold premises at murrayfield house nursing home,edinburgh. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 28. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold premises at annfield house,annfield gardens,stirling. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 26. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums payable to the landlord in the event of a default (as defined).
    Kurze Angaben
    The tenant as beneficial owner charges to the landlord:- 1. initial deposit. 2. all interest. 3. the deposit account. 4. the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 26. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 26. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums payable to the landlord in the event of a default (as defined).
    Kurze Angaben
    The tenant as beneficial owner charges to the landlord:- 1. initial deposit. 2. all interest. 3. the deposit account. 4. the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 26. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 26. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums payable to the landlord in the event of a default (as defined)
    Kurze Angaben
    The tenant as beneficial owner charges to the landlord:- 1. initial deposit. 2. all interest. 3. the deposit account. 4. the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 26. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed
    Kurze Angaben
    Initial deposit, all interest, the deposit account, and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 17. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a default (as defined)
    Kurze Angaben
    The initial deposit,all interest,the deposit account and deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 17. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Kurze Angaben
    The initial deposit all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Kurze Angaben
    The initial deposit, all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a camberwell green care centre 54 camberwell green london. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a erskine hall nursing home watford road northwood. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a falstone manor care centre whitburn road roker sunderland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a nairn house care centre 7 garnault road enfield. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a oban house 46 bramley hill south croydon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a waterside care centre dudley road tipton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a millfield care centre bury new road heywood. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat APTA HEALTHCARE (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praktiker
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0