GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03097890 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 200 Brook Drive Green Park RG2 6UB Reading Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| 03097890 LIMITED | 11. Sept. 2014 | 11. Sept. 2014 |
| WANG HOLDINGS LIMITED | 26. Sept. 1995 | 26. Sept. 1995 |
| INSUREADVICE LIMITED | 04. Sept. 1995 | 04. Sept. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 1 Seiten | DS02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Theo Wolter Eysink als Direktor am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cygnus House 1 the Southwood Crescent Apollo Rise Farnborough Hampshire GU14 0NL zum 200 Brook Drive Green Park Reading Berkshire RG2 6UB am 28. Juli 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alfonso Delfos als Geschäftsführer am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 30. Okt. 2014
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Nov. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYSINK, Theo Wolter | Geschäftsführer | Maanplein 55, 2516 Ck Corporate Control 30000 The Hague Tp5/7 Netherlands | Netherlands | Dutch | 188409910001 | |||||
| ROIJMANS, Arnoud | Geschäftsführer | Brook Drive Green Park RG2 6UB Reading 200 Berkshire England | Netherlands | Dutch | 170803260001 | |||||
| BROWN, Graham Christopher | Sekretär | Flat 4 82 Belsize Park Gardens Hampstead NW3 4NG London | British | 106493880001 | ||||||
| BUTLER, John Joseph | Sekretär | 30 St Marks Place SL4 3BG Windsor Berkshire | British | 51056220001 | ||||||
| HATFIELD, Gordon Eric | Sekretär | 62 St Marys Grove Chiswick W4 3LW London | British | 8310800001 | ||||||
| HATFIELD, Gordon Eric | Sekretär | 62 St Marys Grove Chiswick W4 3LW London | British | 8310800001 | ||||||
| HAWKER, John David | Sekretär | 2 Fydlers Close Kiln Lane Windsor Forest SL4 2DY Windsor Berkshire | British | 54836450001 | ||||||
| HAWKER, John David | Sekretär | 2 Fydlers Close Kiln Lane Windsor Forest SL4 2DY Windsor Berkshire | British | 54836450001 | ||||||
| PICKEN, Charlotte Elizabeth | Sekretär | Basement Flat 71 Lime Grove W12 8EE London | British | 66081250001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| APPLETON, Stuart Neil | Geschäftsführer | 11 Hill Brow BN3 6QG Brighton | England | British | 123453780001 | |||||
| APPLETON, Stuart Neil | Geschäftsführer | 11 Hill Brow BN3 6QG Brighton | England | British | 123453780001 | |||||
| BALDWIN, David Hamilton | Geschäftsführer | High Street Paulton BS39 7QJ Bristol Elm Hayes House Avon | United Kingdom | British | 136371820001 | |||||
| BIGSBY, Keith | Geschäftsführer | 52 Eden Street CB1 1EL Cambridge | British | 44847030002 | ||||||
| BRADY, Tara Christopher | Geschäftsführer | 14 Ellesmere Close E11 1PT London | United Kingdom | British | 145701300001 | |||||
| COOK, Mark | Geschäftsführer | Cygnus House 1 The Southwood Crescent GU14 0NL Apollo Rise Farnborough Hampshire | England | British | 154617450001 | |||||
| DELFOS, Alfonso | Geschäftsführer | Cygnus House 1 The Southwood Crescent GU14 0NL Apollo Rise Farnborough Hampshire | Netherlands | Dutch | 170807080001 | |||||
| DOCTER, Jan Leenhard | Geschäftsführer | Vinkenbaan 64 Bloemendaal 2061 Lr FOREIGN The Netherlands | Dutch | 58850450001 | ||||||
| FAULKNER, Stephen | Geschäftsführer | Portsmouth Road KT6 4HG Surbiton 23 Westfield Court Surrey | United Kingdom | British | 137488750001 | |||||
| HAWKER, John David | Geschäftsführer | 2 Fydlers Close Kiln Lane Windsor Forest SL4 2DY Windsor Berkshire | Uk | British | 54836450001 | |||||
| JANSE VAN VUUREN, Jeremiah Jesaja | Geschäftsführer | Harewood Downs House Amersham Road HP8 4RS Chalfont St. Giles Buckinghamshire | British | 65205740001 | ||||||
| KENEALY, Mark | Geschäftsführer | Fernhill Kidmore Lane RG4 9SH Sonning Common South Oxfordshire | British | 107625200001 | ||||||
| RUCKERT, Axel Rolf | Geschäftsführer | 11 Av Ste Claire Rueil Malmaison 92500 France | German | 92472550001 | ||||||
| VAN DER ENDEN, Eelco Marinus Engelbert | Geschäftsführer | Lage Klompweg 16 D Weesp 1381 Hd Netherlands | Dutch | 92472640001 | ||||||
| VAN LUIJK, Cornelis Gerardus, Drs | Geschäftsführer | Dennenlaan 5 Wassenaar 2244 Al Netherlands | Dutch | 67906280002 | ||||||
| VAN VOORST, Pieter Klaas | Geschäftsführer | Purmerenderweg 138 Zuid-Oost Beemster 1461 Dl FOREIGN The Netherlands | Dutch | 58850300001 | ||||||
| VAN VUUREN, Jeremiah Jesala Janse | Geschäftsführer | Harewood Downs House Amersham Road HP8 4RS Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 46095250002 | ||||||
| WHITCHURCH, Michael | Geschäftsführer | Sailsbury Road BN11 1RB Worthing 3 West Sussex | England | British | 130732580001 | |||||
| WHITEHEAD, Roger Paul | Geschäftsführer | Laurel House Eghams Wood Road HP7 1JU Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 57979620001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat GETRONICS (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A dutch law disclosed pledge of bank accounts | Erstellt am 30. Juli 2003 Geliefert am 15. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any pledgor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The pledgor has granted to the pledgee for the duration of the security period a right of pledge over all of its account rights by means of a disclosed second priority right of pledge the pledgor has granted to the pledgee for the duration of the security period a right of pledge over all of its deposit rights by means of a disclosed first priority right of pledge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security over shares agreement | Erstellt am 30. Juli 2003 Geliefert am 15. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor and each other obligor to the financing parties or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor has charged the shares and related assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security over cash agreement between getronics holdings limited as chargor and abn amro bank N.V. and abn amro bank (luxembourg) S.A. as secured parties (the security over cash agreement) | Erstellt am 30. Juli 2003 Geliefert am 15. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other cash pooling obligor to each secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor has charged the deposit with full title guarantee and by way of first fixed charge to the secured parties the chargor has assigned absolutely to abn amro bank (luxembourg) S.A. with full title guarantee all of its right title and interest in the deposit as amended by the security over cash agreement, floating charge over all present and future assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security over cash agreement | Erstellt am 30. Juli 2003 Geliefert am 15. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor or any other obligor to the finance parties or to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor has charged the deposit with full title guarantee and by way of first fixed charge to the chargee for the payment and discharge of all of the secured obligations the chargor has assigned absolutely to the chargee with full title guarantee (subject only to the cash pooling providers charge) all of the chargors right title and interest in the deposit and a lightweight floating charge over all present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security over cash agreement | Erstellt am 30. Juli 2003 Geliefert am 15. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other corporate facility obligor to the chargee or to each corporate facility provider on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the deposit. All right, title and interest in each deposit. A floating charge over all present and future assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security over shares agreement | Erstellt am 27. Juni 2003 Geliefert am 17. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the financing parties or ot the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the charged portfolio. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 15. Mai 1998 Geliefert am 02. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guaranty dated 13TH may 1998 or any other credit document (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0